I.E. GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামI.E. GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02542977
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    I.E. GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব বা ভাড়াকৃত রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য ভাড়া এবং পরিচালনা (68209) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    I.E. GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    48 Broadway
    PE1 1YW Peterborough
    Cambridgeshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    I.E. GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SEC GROUP PLC২৯ মার্চ, ১৯৯৯২৯ মার্চ, ১৯৯৯
    SECURITISED ENDOWMENT CONTRACTS PLC২২ নভে, ১৯৯০২২ নভে, ১৯৯০
    REALBOND PLC২৫ সেপ, ১৯৯০২৫ সেপ, ১৯৯০

    I.E. GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৪

    I.E. GROUP LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    I.E. GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ অক্টো, ২০১৪

    ০৯ অক্টো, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,264,402
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ অক্টো, ২০১৩

    ১৮ অক্টো, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,264,402
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ ডিসে, ২০১১ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ জুন, ২০১১ তারিখে Mr. Michael Alastair Couzens-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Paul Hooper এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Michael Couzens এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Ms Marie Fiona Fisher-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Diana Monger এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    বিবিধ

    Section 519
    4 পৃষ্ঠাMISC

    পরিচালক হিসাবে Mark Wadelin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Paul Hooper-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mrs Diana Monger-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    I.E. GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    FISHER, Marie Fiona
    Broadway
    PE1 1YW Peterborough
    48
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    Broadway
    PE1 1YW Peterborough
    48
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish157495860001
    DRAIN, Antony Peter
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    সচিব
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    British60698090001
    ELLIS, Robert Gordon
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    সচিব
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    British33165610001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    সচিব
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    সচিব
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    MONGER, Diana
    Verdley Place
    Fernhurst
    GU27 3ER Haslemere
    Oefield House
    Surrey
    সচিব
    Verdley Place
    Fernhurst
    GU27 3ER Haslemere
    Oefield House
    Surrey
    148091340001
    PINNICK, Jeffrey
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    সচিব
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    British8659220002
    RENNIE, Kim Michelle
    58 Oxhey Avenue
    WD1 4HA Watford
    Hertfordshire
    সচিব
    58 Oxhey Avenue
    WD1 4HA Watford
    Hertfordshire
    British65899240002
    TRUEMAN, Paul Roland
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    সচিব
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    British9145660001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    সচিব
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILKINSON, Alan Steven
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    সচিব
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    British61982590001
    S F (FINANCIAL AND MANAGEMENT) SERVICES LIMITED
    23-25 Eastcastle Street
    W1N 8AE London
    কর্পোরেট সচিব
    23-25 Eastcastle Street
    W1N 8AE London
    16340140001
    ANSELL, Nicholas Paul
    Hetlee Farm Leigh Road
    SK9 6DS Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    Hetlee Farm Leigh Road
    SK9 6DS Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish48033090001
    ATTWOOD, Thomas Roger
    Manor House
    Gills Green
    TN18 5AE Cranbrook Hawkshurst
    Kent
    পরিচালক
    Manor House
    Gills Green
    TN18 5AE Cranbrook Hawkshurst
    Kent
    United KingdomBritish50051050001
    BARNARD, Nigel Parry
    19 Roehampton Court
    Queens Ride Barnes
    SW13 0HU London
    পরিচালক
    19 Roehampton Court
    Queens Ride Barnes
    SW13 0HU London
    DenmarkBritish48030310001
    COLLINS, Adrian John Reginald
    4 Campden Hill Square
    W8 7LB London
    পরিচালক
    4 Campden Hill Square
    W8 7LB London
    EnglandBritish465730003
    COUZENS, Michael Alastair
    Nell Hill
    Hannington
    SN6 7RU Wilstshire
    Nell House
    England
    England
    পরিচালক
    Nell Hill
    Hannington
    SN6 7RU Wilstshire
    Nell House
    England
    England
    United KingdomBritish75553130006
    DRAIN, Antony Peter
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    পরিচালক
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    United KingdomBritish60698090001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    পরিচালক
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    GREENWOOD, Timothy Sandiford
    Herons Brook
    Chelford Road Prestbury
    SK10 4AW Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    Herons Brook
    Chelford Road Prestbury
    SK10 4AW Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish101284380001
    HOOPER, Paul
    London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Little Shipton
    Gloucester
    United Kingdom
    পরিচালক
    London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Little Shipton
    Gloucester
    United Kingdom
    United KingdomBritish152500600001
    KALISH, Geoffrey
    780 Third Avenue Ninth Floor
    Newyork
    Usa
    পরিচালক
    780 Third Avenue Ninth Floor
    Newyork
    Usa
    American64379780001
    KLUG, Bernard Philip
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    পরিচালক
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    British15387060001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    পরিচালক
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    PINNICK, Jeffrey
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    পরিচালক
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritish8659220002
    RADCLIFFE, Mark Hugh Joseph
    The Malt House
    Upton, Nr Andover
    SP11 0JS Andover
    Hampshire
    পরিচালক
    The Malt House
    Upton, Nr Andover
    SP11 0JS Andover
    Hampshire
    British33402910003
    ROBSON, Rupert Hugo Wynne
    2 Carlyle Mansions
    Cheyne Walk
    SW3 5LS London
    পরিচালক
    2 Carlyle Mansions
    Cheyne Walk
    SW3 5LS London
    British9727390002
    ROSENZWEIG, Max
    7 Williams Way
    WD7 7EZ Radlett
    Hertfordshire
    পরিচালক
    7 Williams Way
    WD7 7EZ Radlett
    Hertfordshire
    British74961040001
    TRUEMAN, Paul Roland
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    পরিচালক
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish9145660001
    WADELIN, Mark Thomas
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    পরিচালক
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish70575020005
    WADELIN, Mark Thomas
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    পরিচালক
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish70575020005
    WEBSTER, John Dudley
    10 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    পরিচালক
    10 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    British457110001
    WILKINSON, Alan Steven
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    পরিচালক
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    British61982590001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Burleigh House
    Chapel Oak Salford Priors
    WR11 8SP Evesham
    কর্পোরেট পরিচালক
    Burleigh House
    Chapel Oak Salford Priors
    WR11 8SP Evesham
    82547250002

    I.E. GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all "deposits" in and to the charged account with barclays bank PLC re;-sec group PLC business premium account no;-00928852. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ জুন, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ জুন, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ এপ্রি, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter-indemnity of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge all its right title and interest in respect of:- the account held by the company with the bank at 38 mosley street manchester designated "the royal bank of scotland PLC - cash deposit be sec group PLC to support guarantee liability" under account number 20122924 (or such other replacement (account(s) in which the new deposit is held (the "new account")) and amount from time to time standing to the credit of the account and all rights accruing in respect of the new account. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge over cash deposit
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a counter-indemnity of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its right, title and interest in:- the account held by the company with the bank designated "rbs : re- sec group PLC" under account number:20078186 (the "account"). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage and assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All policies of insurance and all moneys payable thereunder please see doc M200C for details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ডিসে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ সেপ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ সেপ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (For further details see doc 396 tc ref M339C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ সেপ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২১ জুন, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0