SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিরূপান্তরিত / বন্ধ
    আইনি ফর্মরূপান্তরিত / বন্ধ
    কোম্পানি নম্বর 02563625
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7487) /

    SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    NEW SAXON FARM PRODUCTS LIMITED ২৯ নভে, ১৯৯০২৯ নভে, ১৯৯০

    SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়০৪ জানু, ২০১১
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়০৪ অক্টো, ২০১১
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে০২ জানু, ২০১০

    SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ফ্রেন্ডলি সোসাইটির নিবন্ধন শংসাপত্র

    পৃষ্ঠাCERTIPS

    বিবিধ

    Forms b and z to convert to i&ps
    পৃষ্ঠাMISC

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Convert to an i&ps 22/09/2010
    RES13

    ২২ সেপ, ২০১০ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    পৃষ্ঠাSH01

    ২২ সেপ, ২০১০ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    পৃষ্ঠাSH01

    সচিব হিসাবে Stephen Parry-এর নিয়োগ

    পৃষ্ঠাAP03

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ০২ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    পৃষ্ঠাAA

    ০১ আগ, ২০১০ তারিখে Mr Timothy Hurrell-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    পৃষ্ঠাCH01

    ০১ আগ, ২০১০ তারিখে Mr Stephen Humes-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ০২ মে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    পৃষ্ঠাAA

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ২৭ এপ্রি, ২০১০ থেকে ০৪ জানু, ২০১০ পর্যন্ত

    পৃষ্ঠাAA01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    পৃষ্ঠাAD01

    সচিব হিসাবে Emily Martin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে William Robson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Mrs Caroline Jane Sellers-এর নিয়োগ

    পৃষ্ঠাAP03

    legacy

    পৃষ্ঠা363a

    legacy

    পৃষ্ঠা403a

    legacy

    পৃষ্ঠা288b

    legacy

    পৃষ্ঠা288a

    legacy

    পৃষ্ঠা288b

    legacy

    পৃষ্ঠা288b

    legacy

    পৃষ্ঠা288a

    legacy

    পৃষ্ঠা288b

    legacy

    পৃষ্ঠা288a

    SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PARRY, Stephen
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    সচিব
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    154306180001
    SELLERS, Caroline Jane
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    সচিব
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    146968750001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    পরিচালক
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    পরিচালক
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager Food Group99724260001
    FAIRCLOUGH, Nicholas Humphrey
    Peckforton Hall
    Peckforton Hall Lane, Peckforton
    CW6 9TH Tarporley
    Cheshire
    সচিব
    Peckforton Hall
    Peckforton Hall Lane, Peckforton
    CW6 9TH Tarporley
    Cheshire
    BritishCheshire67981940001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    HAWKINS, Carolynne
    26 Sandhurst Drive
    Aintree
    L10 6LX Liverpool
    Merseyside
    সচিব
    26 Sandhurst Drive
    Aintree
    L10 6LX Liverpool
    Merseyside
    British45041470002
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    সচিব
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    BritishCompany Secretary91828160006
    HERON, Beryl Mary
    Flat 5 Beechwood Court
    Maghull
    L31 6EG Liverpool
    Merseyside
    সচিব
    Flat 5 Beechwood Court
    Maghull
    L31 6EG Liverpool
    Merseyside
    British20544550001
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    সচিব
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    BritishCompany Secretary115285710001
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    পরিচালক
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritishFinance Director85825120001
    BICKERSTAFFE, Katie
    Aston Lodge
    5 Highdale Road
    BS21 7UW Clevedon
    Avon
    পরিচালক
    Aston Lodge
    5 Highdale Road
    BS21 7UW Clevedon
    Avon
    BritishCompany Director110621690001
    BOWLER, Graeme John
    10 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    পরিচালক
    10 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    AustralianManaging Dir & Chief Executive36127280002
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    পরিচালক
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritishCompany Director74956170001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    পরিচালক
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    BritishRetail Director111624590001
    FAIRCLOUGH, Nicholas Humphrey
    Peckforton Hall
    Peckforton Hall Lane, Peckforton
    CW6 9TH Tarporley
    Cheshire
    পরিচালক
    Peckforton Hall
    Peckforton Hall Lane, Peckforton
    CW6 9TH Tarporley
    Cheshire
    BritishSolicitor67981940001
    GATTO, Salvatore Martin
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    পরিচালক
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    United KingdomBritishFinance Director37327260002
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Secretary20888800002
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    BritishDirector91828160003
    HERON, Beryl Mary
    Flat 5 Beechwood Court
    Maghull
    L31 6EG Liverpool
    Merseyside
    পরিচালক
    Flat 5 Beechwood Court
    Maghull
    L31 6EG Liverpool
    Merseyside
    BritishDirector20544550001
    MASON, Paul
    Moor Lane
    Burley Woodhead
    LS29 7SW Ilkley
    Moorlands
    West Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Moor Lane
    Burley Woodhead
    LS29 7SW Ilkley
    Moorlands
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141310720001
    MILLS, Fredrick Reginald
    10 Hall Lane
    Connahs Quay
    CH5 4LX Deeside
    Clwyd
    পরিচালক
    10 Hall Lane
    Connahs Quay
    CH5 4LX Deeside
    Clwyd
    BritishDeputy Managing Director33349390001
    MOFFAT, Simon Alexander
    11 The Park
    Christleton
    CH3 7AR Chester
    Cheshire
    পরিচালক
    11 The Park
    Christleton
    CH3 7AR Chester
    Cheshire
    BritishGroup Finance Director41139540001
    MURPHY, John Conan
    Moor Hall
    Prescot Road
    L39 6RT Ormskirk
    Lancashire
    পরিচালক
    Moor Hall
    Prescot Road
    L39 6RT Ormskirk
    Lancashire
    BritishCompany Director80004900001
    OAKES, Martin Nicholas
    Oakhurst House
    Fulready, Ettington
    CV37 7PE Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    Oakhurst House
    Fulready, Ettington
    CV37 7PE Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishLogistics Director86206380002
    PRETTY, Derek William Methven
    18 Richmond Hill
    Clifton
    BS8 1BA Bristol
    Avon
    পরিচালক
    18 Richmond Hill
    Clifton
    BS8 1BA Bristol
    Avon
    United KingdomBritishFinancial Executive65944140001
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    পরিচালক
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director57803420002
    SEABROOK, Graeme
    29 Curzon Park South
    CH4 8AA Chester
    Cheshire
    পরিচালক
    29 Curzon Park South
    CH4 8AA Chester
    Cheshire
    AustralianChief Executive3911900001
    SMITH, Colin George
    Tallius
    Jubilee Road, Finchampstead
    RG40 3SR Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    Tallius
    Jubilee Road, Finchampstead
    RG40 3SR Wokingham
    Berkshire
    BritishDirector111628890001

    SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any senior creditor and any pik creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জুন, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any rcf creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ জুল, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A target group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any senior creditor and any pik creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৮ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জুন, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0