LT HEALTHCARE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLT HEALTHCARE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02566174
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LT HEALTHCARE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9999) /

    LT HEALTHCARE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Majestic House
    34 Mansfield Road
    DE75 7AQ Heanor
    Derbyshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LT HEALTHCARE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    JEWELMATCH LIMITED০৬ ডিসে, ১৯৯০০৬ ডিসে, ১৯৯০

    LT HEALTHCARE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০০৮

    LT HEALTHCARE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৮ ডিসে, ২০০৯

    ০৮ ডিসে, ২০০৯ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    ০৮ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Mariko Barbara Pratap-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৮ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Erica Jayne Hart-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৮ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Roger William Mohan Pratap-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৮ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Steven Christopher Oakes-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৮ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Steven Christopher Oakes-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    LT HEALTHCARE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    OAKES, Steven Christopher
    34 Mansfield Road
    DE75 7AQ Heanor
    Majestic House
    Derbyshire
    সচিব
    34 Mansfield Road
    DE75 7AQ Heanor
    Majestic House
    Derbyshire
    BritishDirector134687460001
    HART, Erica Jayne
    34 Mansfield Road
    DE75 7AQ Heanor
    Majestic House
    Derbyshire
    পরিচালক
    34 Mansfield Road
    DE75 7AQ Heanor
    Majestic House
    Derbyshire
    United KingdomBritishCare Home Operator72377170001
    OAKES, Steven Christopher
    34 Mansfield Road
    DE75 7AQ Heanor
    Majestic House
    Derbyshire
    পরিচালক
    34 Mansfield Road
    DE75 7AQ Heanor
    Majestic House
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector134687460001
    PRATAP, Mariko Barbara
    34 Mansfield Road
    DE75 7AQ Heanor
    Majestic House
    Derbyshire
    পরিচালক
    34 Mansfield Road
    DE75 7AQ Heanor
    Majestic House
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director129946970001
    PRATAP, Roger William Mohan
    34 Mansfield Road
    DE75 7AQ Heanor
    Majestic House
    Derbyshire
    পরিচালক
    34 Mansfield Road
    DE75 7AQ Heanor
    Majestic House
    Derbyshire
    United KingdomBritishCompany Director117222500001
    PRATAP, Bhoom Raj, Dr
    Manor Lodge
    5 Dunnockswood Alsager
    ST7 2XU Stoke On Trent
    Staffordshire
    সচিব
    Manor Lodge
    5 Dunnockswood Alsager
    ST7 2XU Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishGeneral Practitioner35811520001
    PRATAP, Roger William Mohan
    The Glebe House
    HP17 8UG Dinton
    Buckinghamshire
    সচিব
    The Glebe House
    HP17 8UG Dinton
    Buckinghamshire
    British117222500001
    TAYLOR, Samuel
    Westcroft
    Queens Road
    GY1 1PU St Peter Port
    Guernsey
    সচিব
    Westcroft
    Queens Road
    GY1 1PU St Peter Port
    Guernsey
    British3992730004
    TURNER, Nicholas Robert
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    সচিব
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    BritishFinance Director123183150001
    TAYLOR, Josephine Michele
    Westcroft
    Queen Road
    GY1 1PU St Peters Port
    Guernsey
    পরিচালক
    Westcroft
    Queen Road
    GY1 1PU St Peters Port
    Guernsey
    BritishCompany Director3992740004
    TAYLOR, Samuel
    Westcroft
    Queens Road
    GY1 1PU St Peter Port
    Guernsey
    পরিচালক
    Westcroft
    Queens Road
    GY1 1PU St Peter Port
    Guernsey
    BritishCompany Director3992730004
    TURNER, Nicholas Robert
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishFinance Director123183150001

    LT HEALTHCARE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ অক্টো, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property being milton ernest hall milton ernest bedfordshire t/no BD100871. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ অক্টো, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on all book debts goodwill and uncalled capital all patents trade marks trade names inventions by way of a floating charge over all the see 395 338 c 9/6 for full details. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Milton ernest hall milton ernest bedfordshire with all licenses.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ucb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ মার্চ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Oakfield weston park bath avon assigns all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ucb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ মার্চ, ১৯৯১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    • ১২ মার্চ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0