BOWOOD PARTNERS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBOWOOD PARTNERS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02569473
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BOWOOD PARTNERS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    BOWOOD PARTNERS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    16 Eastcheap
    EC3M 1BD London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BOWOOD PARTNERS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    GRIMSTON INSURANCE SERVICES LIMITED১৯ ডিসে, ১৯৯০১৯ ডিসে, ১৯৯০

    BOWOOD PARTNERS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৪

    BOWOOD PARTNERS LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৬

    BOWOOD PARTNERS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ১৭ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium a/c & other reserve be cancelled 27/05/2016
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানি বাদ দেওয়ার আবেদন প্রত্যাহার করুন

    1 পৃষ্ঠাDS02

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ১১ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Richardson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৮ জুল, ২০১৫

    ২৮ জুল, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 676,650.4
    SH01

    ২৯ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে William David Bloomer-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৯ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Richardson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৯ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Tuffield এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৯ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Mark Thompson-Copsey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ জুন, ২০১৫ থেকে ৩০ সেপ, ২০১৫ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ৩০ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Woodlands Manton Lane Bedford Bedfordshire MK41 7LW থেকে 16 Eastcheap London EC3M 1BDপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২১ জুল, ২০১৪

    ২১ জুল, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 676,650.4
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ জুল, ২০১৩

    ২৩ জুল, ২০১৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    BOWOOD PARTNERS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MOORE, Andrew John
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    সচিব
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    British133845040001
    BLOOMER, William David
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    পরিচালক
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish72374560002
    GRIMSTON, Katherine
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Bucks
    সচিব
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Bucks
    British23550560001
    HATHAWAY, Rodney Francis
    Boxted Church Road
    Great Horkesley
    CO6 4AL Colchester
    Elmdene
    Essex
    সচিব
    Boxted Church Road
    Great Horkesley
    CO6 4AL Colchester
    Elmdene
    Essex
    British61813590002
    TRILLO, David John
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    সচিব
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    British14014360001
    WHITING, Andrew Michael John
    14 Buckden Road
    Brampton
    PE28 4PS Huntingdon
    Cambridgeshire
    সচিব
    14 Buckden Road
    Brampton
    PE28 4PS Huntingdon
    Cambridgeshire
    British38444620001
    ALBON, Philip Ian
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish53364690001
    ANGEL, Alan Paul
    26 Northwick Circle
    HA3 0EE Harrow
    Middlesex
    পরিচালক
    26 Northwick Circle
    HA3 0EE Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish39825440002
    ANGEL, Alan Paul
    9 Aston Avenue
    HA3 0DB Harrow
    Middlesex
    পরিচালক
    9 Aston Avenue
    HA3 0DB Harrow
    Middlesex
    British39825440001
    ARNOLD, David John Middleton
    Flat 308
    Gilbert House
    EC2Y 8BD Barbican
    London
    পরিচালক
    Flat 308
    Gilbert House
    EC2Y 8BD Barbican
    London
    British36584410002
    ARNOLD, David John Middleton
    Abbotshay Cottage
    Ayot St Lawrence
    AL6 9BS St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Abbotshay Cottage
    Ayot St Lawrence
    AL6 9BS St Albans
    Hertfordshire
    British36584410001
    BARNES, Paul
    Shafford Mill
    Childwick Bury
    AL3 6LB St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Shafford Mill
    Childwick Bury
    AL3 6LB St Albans
    Hertfordshire
    EnglandEnglish32833320001
    BONIFACE, Michael John Owen
    Rashleigh Horton Road
    Horton
    DA49 BN Kirby
    Kent
    পরিচালক
    Rashleigh Horton Road
    Horton
    DA49 BN Kirby
    Kent
    United KingdomBritish207125910001
    BRIDGWATER, Paul Charles
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish87505170002
    BRIDGWATER, Paul Charles
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish87505170002
    CAVAZZI, Gary Mark
    Wedgwood Knowl Hill
    The Hockering
    GU22 7HL Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Wedgwood Knowl Hill
    The Hockering
    GU22 7HL Woking
    Surrey
    United KingdomUsa27090250002
    COLLINS, Andrew Dominic John Bucke
    Adlestrop
    GL56 0YN Moreton In Marsh
    Adlestrop Park
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Adlestrop
    GL56 0YN Moreton In Marsh
    Adlestrop Park
    Gloucestershire
    United KingdomBritish139705290001
    COUGHLIN, Alan Alfred
    17 Lampern Crescent
    CM12 0FE Billericay
    Essex
    পরিচালক
    17 Lampern Crescent
    CM12 0FE Billericay
    Essex
    British61617320001
    CURITZ, Maurice Anthony
    Holts Barn Holt Road
    Little Horkesley
    CO6 4DR Colchester
    Essex
    পরিচালক
    Holts Barn Holt Road
    Little Horkesley
    CO6 4DR Colchester
    Essex
    British14791280001
    FAGG, Paul John
    24 Doves Croft
    Tunstall
    ME9 8LQ Sittingbourne
    Kent
    পরিচালক
    24 Doves Croft
    Tunstall
    ME9 8LQ Sittingbourne
    Kent
    United KingdomBritish48990790002
    GAYTON, Ashley Vivian
    The Paddocks
    Lower Road Peldon
    CO5 7PR Colchester
    Essex
    পরিচালক
    The Paddocks
    Lower Road Peldon
    CO5 7PR Colchester
    Essex
    British91623980002
    GINGELL, Timothy
    20 Dorking Road
    KT18 7LX Epsom
    Surrey
    পরিচালক
    20 Dorking Road
    KT18 7LX Epsom
    Surrey
    British50905970002
    GREENER, Stephen Thomas
    Ash Farm House Gravel Lane
    Barton Stacey
    SO21 3RL Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    Ash Farm House Gravel Lane
    Barton Stacey
    SO21 3RL Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish55748330003
    GRIMSTON, Gerald Charles Walter, The Hon
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish12430760001
    HUDSON, John Henry
    Strawberry Fields Long Mill Lane
    Crouch Borough Green
    TN15 8QB Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Strawberry Fields Long Mill Lane
    Crouch Borough Green
    TN15 8QB Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish104588370001
    JEWERS, David John
    Corner Cottage Howe Street
    Great Waltham
    CM3 1BS Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Corner Cottage Howe Street
    Great Waltham
    CM3 1BS Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish113199070001
    MITCHELL, Adrian Edward Michael
    44 Stormont Road
    Battersea
    SW11 5EL London
    পরিচালক
    44 Stormont Road
    Battersea
    SW11 5EL London
    British37610700001
    OVENS, Michael John Meyrick
    15 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    পরিচালক
    15 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    British14990390002
    REED, David Michael
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish159470820001
    RICHARDSON, Ian
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    পরিচালক
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish197592500001
    STANCIK, John David
    259 Mayflower Road
    Lake Forest
    Illinois 60045
    America
    পরিচালক
    259 Mayflower Road
    Lake Forest
    Illinois 60045
    America
    American42367650002
    THOMPSON-COPSEY, Jonathan Mark
    EC3V 1LE London
    One Whittington Avenue
    England
    পরিচালক
    EC3V 1LE London
    One Whittington Avenue
    England
    EnglandBritish146513890002
    TOWNSEND, Philip Michael
    80 Sandford Road
    BR2 9AN Bromley
    Kent
    পরিচালক
    80 Sandford Road
    BR2 9AN Bromley
    Kent
    British40919720002
    TRILLO, David John
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    পরিচালক
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    EnglandBritish14014360001
    TUFFIELD, Andrew
    114 Cardamom Building
    31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    পরিচালক
    114 Cardamom Building
    31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    United KingdomBritish56383230001

    BOWOOD PARTNERS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সর্বশেষ বিবৃতিগুলি কী কী?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
    জানানো হয়েছেবন্ধ হয়েছেবিবৃতি
    ৩০ জুন, ২০১৬কোম্পানি এখনও কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত একজন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা একটি নিবন্ধনযোগ্য প্রাসঙ্গিক আইনি সত্তা আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপগুলি সম্পূর্ণ করেনি

    BOWOOD PARTNERS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Accession deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৩ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ ফেব, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুন, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুল, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Equitable mortgage of land acquired since 28 april 2005 or to be acquired in future. Fixed charge of plant and machinery, goodwill, rights and interest in intellectual property, uncalled share capital, rights and interest in shares and other securities and in contracts. Floating charge of all property and undertaking.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cccc Growth Fund, L.L.C.
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুল, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুন, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুন, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুন, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of variation (made in addition to and modifying the security and trust deed dated 6 october 1997 the "principal deed"))
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The payment of all costs charges expenses and other liabilities properly incurred by the chargee its delegates or agents or any receiver appointed under the security and trust deed in or about the exercise of the powers contained in the security and trust deed (as modified) or otherwise in relation thereto including all remuneration payable to any such receiver and the payment of all debts and obligations for the time being due owing or incurred whether actually or contingently by the company in respect of insurance transactions
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets of the company (and all assets which would be approved).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyd's (A Statutory Corporation)(as Trustee for the Creditors for the Time Being of the Company in Respect of Insurance Transactions)
    ব্যবসায়
    • ২৪ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    As required by lloyd's brokers byelaw (no 5 of 1988) the company has entered into a trust deed under which all insurance broking account assets are subject to a floating charge held on trust by the society of lloyd's for the benefit of the insurance creditors.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Society of Lloyd's
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ আগ, ২০০০বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৭ মে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0