HARTCLIFFE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHARTCLIFFE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02582323
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HARTCLIFFE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    HARTCLIFFE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    I2 Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    Nottinghamshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HARTCLIFFE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SHADOWCALL LIMITED১৩ ফেব, ১৯৯১১৩ ফেব, ১৯৯১

    HARTCLIFFE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৬

    HARTCLIFFE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ০৬ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Bruce Middleton-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০৬ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Donald William Borland এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ ডিসে, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৫ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ciaran Anthony Kennedy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৭ সেপ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Shaun Allen Ormrod-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৬ সেপ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে David John Alexander Ritchie এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ২৫ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Donald William Borland-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২০ ডিসে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১২ জানু, ২০১৬

    ১২ জানু, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 6,450
    SH01

    ০৫ মে, ২০১৫ তারিখে Mr Ciaran Anthony Kennedy-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ মার্চ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David John Alexander Ritchie-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ মার্চ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Eric Andrew Prescott এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৬ জানু, ২০১৫

    ০৬ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 6,450
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ২৩ জুন, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Ciaran Anthony Kennedy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Grant Findlay এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ জানু, ২০১৪

    ১৪ জানু, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 6,450
    SH01

    ১৮ মার্চ, ২০১৩ তারিখে Havelock Europa Plc-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    HARTCLIFFE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MIDDLETON, Bruce
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    সচিব
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    245548680001
    HAVELOCK EUROPA PLC
    Mansfield
    Hamilton Court
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Mansfield
    Hamilton Court
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর782546
    52832210003
    ORMROD, Shaun Allen
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCeo238467880001
    EMERY, Sheila Ann
    The Sands 3 Wichelstok Close
    SN1 4ES Swindon
    Wiltshire
    সচিব
    The Sands 3 Wichelstok Close
    SN1 4ES Swindon
    Wiltshire
    BritishSecretary11596210001
    MUNIESA, Julian
    30 Quarry Road
    SN1 4EN Swindon
    Wilts
    সচিব
    30 Quarry Road
    SN1 4EN Swindon
    Wilts
    EnglishFinancial Director33707640001
    CCS SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001720001
    ASLET, Peter Michael
    26a Cammo Road
    EH4 8AP Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    26a Cammo Road
    EH4 8AP Edinburgh
    Midlothian
    BritishFinancial Executive73615130004
    BALFOUR, Hew Edward Ogilvy
    Vicars Bridge
    Blairingone
    FK14 7NT Dollar
    The Mains Of Arndean
    Clackmannanshire
    পরিচালক
    Vicars Bridge
    Blairingone
    FK14 7NT Dollar
    The Mains Of Arndean
    Clackmannanshire
    United KingdomBritishChief Executive132405720001
    BORLAND, Donald William
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer66010670002
    BUDD, Christopher George
    Bolivia Mount
    The Dhoor
    IM7 4ED Lazayre
    Isle Of Man
    পরিচালক
    Bolivia Mount
    The Dhoor
    IM7 4ED Lazayre
    Isle Of Man
    BritishCompany Director34221640003
    BURNS, Michael Christopher
    12 Orchard Close
    Knightsbridge Court Winterbourne
    BS17 5BZ Bristol
    পরিচালক
    12 Orchard Close
    Knightsbridge Court Winterbourne
    BS17 5BZ Bristol
    BritishManaging Director22451950002
    DE THORPE MILLARD, Brian Percival
    4 Winders Hill Cottages
    Off Quarry Road
    Godstone
    Surrey
    পরিচালক
    4 Winders Hill Cottages
    Off Quarry Road
    Godstone
    Surrey
    BritishManaging Director71472600001
    DENNIS, Arthur
    Cleveland 114 Mancroft Road
    Caddington
    LU1 4EN Luton
    Bedfordshire
    পরিচালক
    Cleveland 114 Mancroft Road
    Caddington
    LU1 4EN Luton
    Bedfordshire
    BritishCompany Director44628980001
    ELLIOTT, Peter Norman
    8 Larch Road
    Kingswood
    BS15 4UQ Bristol
    Avon
    পরিচালক
    8 Larch Road
    Kingswood
    BS15 4UQ Bristol
    Avon
    BritishManaging Director8591740001
    ELLIOTT, Peter Norman
    8 Larch Road
    Kingswood
    BS15 4UQ Bristol
    Avon
    পরিচালক
    8 Larch Road
    Kingswood
    BS15 4UQ Bristol
    Avon
    BritishManaging Director8591740001
    EMERY, Michael Leonard
    The Sands 3 Wichelstok Close
    SN1 4ES Swindon
    Wiltshire
    পরিচালক
    The Sands 3 Wichelstok Close
    SN1 4ES Swindon
    Wiltshire
    BritishAdvertising Executive11596220001
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishGroup Finance Director65759080002
    HUGHES, Philip John
    The Bungalow 241a Lower Way
    Thatcham
    RG19 3TP Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    The Bungalow 241a Lower Way
    Thatcham
    RG19 3TP Newbury
    Berkshire
    BritishFinancial Director16828910001
    JAMES, Terence Ivan
    9 Belle Vue Road
    SN1 3HQ Swindon
    Wiltshire
    পরিচালক
    9 Belle Vue Road
    SN1 3HQ Swindon
    Wiltshire
    BritishSales Director14970780001
    KENNEDY, Ciaran Anthony
    John Smith Business Park
    Grantsmuir Road
    KY2 6NA Kirkcaldy
    Havelock House
    Fife
    Scotland
    পরিচালক
    John Smith Business Park
    Grantsmuir Road
    KY2 6NA Kirkcaldy
    Havelock House
    Fife
    Scotland
    ScotlandNorthern IrishFinance Director43853920003
    MACSPORRAN, Graham
    Rydal 103 Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    Renfrewshire
    পরিচালক
    Rydal 103 Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    Renfrewshire
    BritishAccountant71376370001
    MATTHEWS, Anthony
    The New House
    Main Street Compton Martin
    Bristol
    Avon
    পরিচালক
    The New House
    Main Street Compton Martin
    Bristol
    Avon
    BritishWorks Director43954830001
    MUNIESA, Julian
    44 Stafford Road
    St Werburghs
    BS2 9UN Bristol
    পরিচালক
    44 Stafford Road
    St Werburghs
    BS2 9UN Bristol
    EnglishFinancial Director33707640002
    PRESCOTT, Eric Andrew
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    England
    পরিচালক
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritishCompany Director154581430001
    RITCHIE, David John Alexander
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    ScotlandBritishDirector279706260001
    SCANNELL, Patrick John
    20 Rugby Road
    Dunchurch
    CV22 6PN Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    20 Rugby Road
    Dunchurch
    CV22 6PN Rugby
    Warwickshire
    BritishAccountant8097790001
    THOMSON, George
    14 Birch Grove
    SL4 5RT Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    14 Birch Grove
    SL4 5RT Windsor
    Berkshire
    BritishBusiness Development Director24638370001
    WEBSTER, John Strachan
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Lanarkshire
    BritishFinance Director718070001
    CCS DIRECTORS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001710001

    HARTCLIFFE LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Hamilton Court
    NG18 5FB Mansfield
    I2 Mansfield
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Hamilton Court
    NG18 5FB Mansfield
    I2 Mansfield
    England
    না
    আইনি ফর্মPlc
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষEnglish Law
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর00782546
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    HARTCLIFFE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land and buildings at cater road bishopsworth bristol t/no: AV100051 by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge of whole
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £160,000 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the south side of cater road bishopsworth bristol t/no: AV100051.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Somerfield Stores Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a secured loan note 1995/1998 of £100,000 on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property at 11-16 cater road, bishopsworth, bristol and ground floor 4 high street, swindon wiltshire .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Ventures Investments Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Sakuria auto printing press-serial no. RJ100393. William crossland punch-serial no.230/nk. Sias print serifast printing press-serial no.924228. Sias print serifast printing press-serial no.93287.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৫ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Collateral debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from mediumrent limited to the chargee under the terms of a secured loan note 1993/1996 of £150,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property situate at 11-16 cater road, bishopsworth bristol, l/h property situate at ground floor, 4 high street, swindon, wilts.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Investment Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৫ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ আগ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 29/3/83 and/or the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £10,000 in an account with national westminister bank PLC.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hannick Homes and Developments Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0