HERON HOLDINGS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHERON HOLDINGS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02585408
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HERON HOLDINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ব্যবহৃত গাড়ি এবং হালকা মোটরযান বিক্রয় (45112) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    HERON HOLDINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Barclays Bank Chambers
    Market Street
    HX7 6AD Hebden Bridge
    West Yorkshire
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HERON HOLDINGS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HERON GRANTHAM LIMITED০২ ডিসে, ১৯৯৩০২ ডিসে, ১৯৯৩
    KEY WEST (GRANTHAM) LIMITED১০ মে, ১৯৯১১০ মে, ১৯৯১
    LEONAWAY ENTERPRISES LIMITED২৫ ফেব, ১৯৯১২৫ ফেব, ১৯৯১

    HERON HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৩

    HERON HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    HERON HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ১৪ ফেব, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা The Birches 2a Marlowe Drive Balderton Newark Nottinghamshire NG24 3QZ England থেকে Barclays Bank Chambers Market Street Hebden Bridge West Yorkshire HX7 6ADপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ১৯ মার্চ, ২০১৪ তারিখে Mrs Veronica Jane Knill Theobald-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ১৯ মার্চ, ২০১৪ তারিখে Mrs Veronica Jane Knill Theobald-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১৯ মার্চ, ২০১৪ তারিখে Mr Michael David Theobald-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ ফেব, ২০১৪

    ২৬ ফেব, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 361,950
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    accounts-with-accounts-type-

    7 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ ডিসে, ২০১০ থেকে ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mrs Veronica Jane Knill Theobald-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে David Hodgson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    HERON HOLDINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    THEOBALD, Veronica Jane Knill
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    সচিব
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    154350610001
    THEOBALD, Michael David
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    পরিচালক
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish26464880003
    THEOBALD, Veronica Jane Knill
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    পরিচালক
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish29141950002
    HODGSON, David William
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    সচিব
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    British47003620002
    THEOBALD, Veronica Jane Knill
    18 The Lawns
    Collingham
    NG23 7NT Newark
    Nottinghamshire
    সচিব
    18 The Lawns
    Collingham
    NG23 7NT Newark
    Nottinghamshire
    British29141950001
    WAYGOOD WEST, Caroline Ann
    Swanage Farm
    Washpond Lane
    BH19 1QA Swanage
    Dorset
    সচিব
    Swanage Farm
    Washpond Lane
    BH19 1QA Swanage
    Dorset
    British75388970001
    WAYGOOD-WEST, Kevin
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    সচিব
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    British32923670001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    CLIFFORD, Stephen John
    67 Olney Road
    Emberton
    MK46 5BU Olney
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    67 Olney Road
    Emberton
    MK46 5BU Olney
    Buckinghamshire
    British43921070001
    FELL, John Michael
    59 Cliffe Road
    Ryhope Village
    SR2 0NW Sunderland
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    59 Cliffe Road
    Ryhope Village
    SR2 0NW Sunderland
    Tyne & Wear
    British56249460001
    GREGORY, Robert
    48 Holmefield
    Farndon
    NG24 3TZ Newark
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    48 Holmefield
    Farndon
    NG24 3TZ Newark
    Nottinghamshire
    British47003560001
    HEATHER, Philip William
    2 Spring Close
    Colwall
    WR13 6RE Malvern
    Worcestershire
    পরিচালক
    2 Spring Close
    Colwall
    WR13 6RE Malvern
    Worcestershire
    English35271660001
    HODGSON, David William
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    পরিচালক
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish47003620002
    ICETON, Ian Gordon
    7 Wharf View
    MK18 1XF Buckingham
    পরিচালক
    7 Wharf View
    MK18 1XF Buckingham
    British53359540001
    WAYGOOD-WEST, Kevin
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    পরিচালক
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    British32923670001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    HERON HOLDINGS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    General charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ আগ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ আগ, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the companys assets present & future (including uncalled capital).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies owing to the company by V.A.G. (united kingdom) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to V.A.G. (united kingdom) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    General charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's assets present and future (including uncalled capital).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • V.A.G. Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    General charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's assets present and future (including uncalled capital).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ আগ, ১৯৯২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an offer letter dated 30TH may 1991
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land and premises situate at spittlegate level, grantham, lincs. As described in a lease dated 13.6.91. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • V.A.G. (United Kingdom) Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & premises k/a keywest (grantham) limited,spittlegate level,grantham,lincolnshire and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ডিসে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ ফেব, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ১৯৯১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies owing to the company in respect of refunds of monies paid by the company to V.A.G. (united kingdom) LTD. See 395 for details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুন, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জুল, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জুল, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ ফেব, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0