MIKE WALKER DISTRIBUTION LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMIKE WALKER DISTRIBUTION LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02587762
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MIKE WALKER DISTRIBUTION LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    MIKE WALKER DISTRIBUTION LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Jenna House
    North Crawley Road
    MK16 9TG Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MIKE WALKER DISTRIBUTION LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    VELOCITY 132 LIMITED০১ মার্চ, ১৯৯১০১ মার্চ, ১৯৯১

    MIKE WALKER DISTRIBUTION LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০১৭
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০১৭
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৬

    MIKE WALKER DISTRIBUTION LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৩ মার্চ, ২০১৬

    ০৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 150
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ 4 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 5 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ মার্চ, ২০১৫

    ০২ মার্চ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 150
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ মার্চ, ২০১৪

    ১০ মার্চ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 150
    SH01

    ২৫ ফেব, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 150
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Kameljit Bath এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Steven Tough এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr Barry John Head-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Michael Lawrence এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    MIKE WALKER DISTRIBUTION LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    DAVIDSON, Adrian Cyril
    68 Withies Park
    Midsomer Norton
    BA3 2PA Radstock
    Avon
    পরিচালক
    68 Withies Park
    Midsomer Norton
    BA3 2PA Radstock
    Avon
    EnglandBritishAccountant112197350001
    HEAD, Barry John
    c/o Crown Products (Kent) Ltd
    Eddington Lane
    CT6 5TR Herne Bay
    Eddington Works
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    c/o Crown Products (Kent) Ltd
    Eddington Lane
    CT6 5TR Herne Bay
    Eddington Works
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director34360800002
    BATH, Kameljit
    111 Linceslade Grove
    MK5 8AD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    সচিব
    111 Linceslade Grove
    MK5 8AD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishAccountant93238530001
    HUTCHINSON, Timothy
    Heron House
    Ranby
    DN22 8HR Retford
    সচিব
    Heron House
    Ranby
    DN22 8HR Retford
    BritishDirector88382490001
    POOLE, Michael Gordon
    20 Sunnyvale Drive
    Longwell Green
    BS30 9YH Bristol
    সচিব
    20 Sunnyvale Drive
    Longwell Green
    BS30 9YH Bristol
    British56846260001
    SPENCER, Michael John
    40 Rownham Mead
    BS8 4YB Bristol
    সচিব
    40 Rownham Mead
    BS8 4YB Bristol
    BritishDirector66027580001
    STEEL, Steven John
    16 Thornton Close
    Crick
    NN6 7GE Northampton
    Northamptonshire
    সচিব
    16 Thornton Close
    Crick
    NN6 7GE Northampton
    Northamptonshire
    BritishCertified Accountant109982220001
    SZABO, Stephen Charles
    20 Cumbria Close
    Thornbury
    BS35 2YE Bristol
    সচিব
    20 Cumbria Close
    Thornbury
    BS35 2YE Bristol
    British101288510001
    TILLER, Frank Barry
    14 New Forest Lane
    IG7 5QN Chigwell
    Essex
    সচিব
    14 New Forest Lane
    IG7 5QN Chigwell
    Essex
    British7326520003
    VELOCITY COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Orchard Court
    Orchard Lane
    BS1 5DS Bristol
    Avon
    কর্পোরেট সচিব
    Orchard Court
    Orchard Lane
    BS1 5DS Bristol
    Avon
    85909670001
    VELOCITY COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Orchard Court
    Orchard Lane
    BS1 5DS Bristol
    Avon
    কর্পোরেট সচিব
    Orchard Court
    Orchard Lane
    BS1 5DS Bristol
    Avon
    85909670001
    BOULTON, Anthony John Prior
    Strumperstrasse 43
    D4005 Meerbusch 2
    Germany
    পরিচালক
    Strumperstrasse 43
    D4005 Meerbusch 2
    Germany
    BritishDirector27181220001
    HONER, Christopher David
    17 Somerset Close
    Kingswood
    GL12 8RQ Wooton Under Edge
    Gloucestershire
    পরিচালক
    17 Somerset Close
    Kingswood
    GL12 8RQ Wooton Under Edge
    Gloucestershire
    BritishSales Director111511760001
    LAWRENCE, Michael Warwick
    Rectory Grange
    Petsoe End
    MK46 5JL Olney
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Rectory Grange
    Petsoe End
    MK46 5JL Olney
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishExecutive Director33280980005
    MULLIGAN, Patrick Charles
    53 Oakham Road
    DY2 7TE Dudley
    West Midlands
    পরিচালক
    53 Oakham Road
    DY2 7TE Dudley
    West Midlands
    EnglandBritishDirector43003690001
    POOLE, Michael Gordon
    20 Sunnyvale Drive
    Longwell Green
    BS30 9YH Bristol
    পরিচালক
    20 Sunnyvale Drive
    Longwell Green
    BS30 9YH Bristol
    BritishCompany Director56846260001
    SPENCER, Michael John
    40 Rownham Mead
    BS8 4YB Bristol
    পরিচালক
    40 Rownham Mead
    BS8 4YB Bristol
    United KingdomBritishManaging Director66027580001
    STEEL, Steven John
    16 Thornton Close
    Crick
    NN6 7GE Northampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    16 Thornton Close
    Crick
    NN6 7GE Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishCertified Accountant109982220001
    SZABO, Stephen Charles
    20 Cumbria Close
    Thornbury
    BS35 2YE Bristol
    পরিচালক
    20 Cumbria Close
    Thornbury
    BS35 2YE Bristol
    BritishFinancial Director101288510001
    TILLER, Frank Barry
    14 New Forest Lane
    IG7 5QN Chigwell
    Essex
    পরিচালক
    14 New Forest Lane
    IG7 5QN Chigwell
    Essex
    BritishChartered Accountant7326520003
    TOUGH, Steven James
    14 Cae Garw Bach
    St Fagans
    CF5 6HH Cardiff
    পরিচালক
    14 Cae Garw Bach
    St Fagans
    CF5 6HH Cardiff
    WalesBritishSales101288490001
    WALKER, Herbert Michael
    Morgans
    East Harptree
    BS40 6AG Bristol
    Avon
    পরিচালক
    Morgans
    East Harptree
    BS40 6AG Bristol
    Avon
    United KingdomBritishCompany Director17136770001
    VELOCITY COMPANY (HOLDINGS) LIMITED
    Orchard Court
    Orchard Lane
    BS1 5DS Bristol
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Orchard Court
    Orchard Lane
    BS1 5DS Bristol
    Avon
    900002330001

    MIKE WALKER DISTRIBUTION LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জানু, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charges over all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Crown Products (Kent) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ জানু, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জানু, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জানু, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ জানু, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুন, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Venture Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুন, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    All assets debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property--unit 3 clutton hill estate,king lane,clutton,bristol. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Wales PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ জুল, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৭ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0