TEREX LIFTING U.K. LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTEREX LIFTING U.K. LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02602451
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TEREX LIFTING U.K. LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • লিফট এবং হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম উত্পাদন (28220) / উৎপাদন

    TEREX LIFTING U.K. LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TEREX LIFTING U.K. LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MATBRO LIMITED১৬ আগ, ১৯৯১১৬ আগ, ১৯৯১
    FORAY 292 LIMITED১৭ এপ্রি, ১৯৯১১৭ এপ্রি, ১৯৯১

    TEREX LIFTING U.K. LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৫

    TEREX LIFTING U.K. LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২৯ জুন, ২০১৭ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ২৩ জুন, ২০১৭ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,500,003
    3 পৃষ্ঠাSH01

    ১৭ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ২৭ ফেব, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Daniel Sheehan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ ফেব, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kevin Patrick Bradley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৫ এপ্রি, ২০১৬

    ২৫ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,500,002
    SH01

    ১১ ডিসে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ronald Matthew Defeo এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ এপ্রি, ২০১৫

    ১৭ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,500,002
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৮ এপ্রি, ২০১৪

    ২৮ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,500,002
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Mr Kevin Patrick Bradley-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Phillip Widman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ১৭ এপ্রি, ২০১২ তারিখে Mr Ronald Matthew Defeo-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    TEREX LIFTING U.K. LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    সচিব
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    American65582430009
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    পরিচালক
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    United StatesAmerican65582430009
    SHEEHAN, John Daniel
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    পরিচালক
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    United StatesAmerican226001330001
    BROOKES, Howard Maurice
    14 Ryknild Close
    Four Oaks
    B74 4UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    সচিব
    14 Ryknild Close
    Four Oaks
    B74 4UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British662930001
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    সচিব
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    MANDERS, Douglas Nigel
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    মনোনীত সচিব
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    British900003700001
    APUZZO, Joseph
    190 Sturges Ridge Road
    Wilton
    Fairfield
    06897
    Usa
    পরিচালক
    190 Sturges Ridge Road
    Wilton
    Fairfield
    06897
    Usa
    American66269020001
    BAILLIE, Fergus Cumming
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    পরিচালক
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    British924340002
    BRADLEY, Kevin Patrick
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    United Kingdom
    পরিচালক
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    United Kingdom
    Untied States Of AmericaAmerican176590390001
    COSGROVE, Barry
    11 Adair Avenue
    BT80 8PU Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    পরিচালক
    11 Adair Avenue
    BT80 8PU Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    British13991920001
    CRAIG, John Egwin
    Saxonbury House
    Frant
    TN3 9HJ Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    Saxonbury House
    Frant
    TN3 9HJ Tunbridge Wells
    Kent
    British15697900001
    DEFEO, Ronald Matthew
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    পরিচালক
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    United StatesAmerican94656950001
    DOOEY, Hugh Pat
    14 Usnastraine Road
    BT71 5DE Coalisland
    Tyrone
    N Ireland
    পরিচালক
    14 Usnastraine Road
    BT71 5DE Coalisland
    Tyrone
    N Ireland
    Northern IrelandIrish115095900001
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    HOLMES, Edward
    Rushford House Rushford Bridge
    GL12 8JW Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Rushford House Rushford Bridge
    GL12 8JW Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British55964730001
    KENNERLEY, John Frank William
    Old Westwick
    Chantry View Road
    GU1 3XW Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Old Westwick
    Chantry View Road
    GU1 3XW Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish69793560001
    MANDERS, Douglas Nigel
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    মনোনীত পরিচালক
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    British900003700001
    MCGRATH, Brendan
    13 Newent Close
    Winyates Green
    B98 0QW Redditch
    Worcestershire
    পরিচালক
    13 Newent Close
    Winyates Green
    B98 0QW Redditch
    Worcestershire
    Irish38927470001
    MCKEOWN, Shay
    41 Tullycullion Road
    Dungannon
    County Tyrone
    Northern Ireland
    পরিচালক
    41 Tullycullion Road
    Dungannon
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Irish40247040001
    MURCHAN, Seamus Michael
    2 Ferndale
    Clonallon Road
    BT34 3FE Warrenpoint
    County Down
    পরিচালক
    2 Ferndale
    Clonallon Road
    BT34 3FE Warrenpoint
    County Down
    Northern IrelandNorthern Irish182530670001
    NICHOLSON SMITH, James Timothy
    Kings Farm
    Stockwell Lane, Woodmancote
    GL52 4QB Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Kings Farm
    Stockwell Lane, Woodmancote
    GL52 4QB Cheltenham
    Gloucestershire
    British70851540001
    NOONE, Liam
    121 Malmesbury Road
    SN15 1PZ Chippenham
    Wiltshire
    পরিচালক
    121 Malmesbury Road
    SN15 1PZ Chippenham
    Wiltshire
    Irish47114340001
    REES, Andrew Merfyn
    114 Vivian Road
    Harborne
    B17 0DJ Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    114 Vivian Road
    Harborne
    B17 0DJ Birmingham
    West Midlands
    British3425330001
    RICE, Michael Joseph
    The Street
    GL9 1HH Acton Turville
    Greenfields
    Gloucestershire
    পরিচালক
    The Street
    GL9 1HH Acton Turville
    Greenfields
    Gloucestershire
    United KingdomBritish140087640001
    ROBERTSON, Colin
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    পরিচালক
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    British77076440001
    WATSON, Hubert John
    20 Victoria Grove
    Dollingstown Lurgan
    BT66 7JJ Craigavon
    County Armagh
    পরিচালক
    20 Victoria Grove
    Dollingstown Lurgan
    BT66 7JJ Craigavon
    County Armagh
    British56996050003
    WIDMAN, Phillip Charles
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    পরিচালক
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    UsaAmerican144249950001

    TEREX LIFTING U.K. LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর03720364
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    TEREX LIFTING U.K. LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed charge on book and other debts
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on all book debts and other debts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Banks PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Smurfit Paribas Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland,as Security Trustee for the Secured Parties(As Defined)
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    In favour of the governor and company of the bank of ireland as security trustee for the banks ("the secured parties") all monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them whether collectively or individually by the company either alone or jointly with any person or company on any account under the terms and conditions as defined in the composite debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A fixed charge over all the companys f/h and l/h lands hereditaments, premises, property and chattels both present and future including the property particulars of which are specified under the company's name in the second schedule hereto and all the company's interests in all buildings, fixtures (including, without limitation, trade fixtures) and the fixed plant and machinery from time to time thereon; all present and future plant machinery vehicles fixtures implements utensils and equipment, all goodwill and uncalled capital and all debts; floating charge over the book debts undertaking and all other property assets and rights whatsoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Irelandas Security Trustee for the Banks ("the Securedparties")
    ব্যবসায়
    • ১৬ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0