PARK ROSE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPARK ROSE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02610531
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PARK ROSE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (2625) /
    • (5246) /

    PARK ROSE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Chapel
    Bridge Street
    YO25 6DA Driffield
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PARK ROSE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ALPHABOURNE LIMITED১৪ মে, ১৯৯১১৪ মে, ১৯৯১

    PARK ROSE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১১

    PARK ROSE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    13 পৃষ্ঠাLIQ14

    ১৯ জুল, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    12 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৫ নভে, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Maclaren House Skerne Road Driffield YO25 6PN থেকে The Chapel Bridge Street Driffield YO25 6DAপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১৯ জুল, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    10 পৃষ্ঠা4.68

    ১৯ জুল, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    10 পৃষ্ঠা4.68

    ১৯ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠা4.68

    ১৯ জুল, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠা4.68

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    5 পৃষ্ঠা4.20

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন

    LRESEX

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    সচিব হিসাবে Stephen Cann এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Beverly Berryman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Stephen Cann এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ জুল, ২০১১

    ০১ জুল, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 90,000
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    PARK ROSE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    DYER, Trevor Gordon
    Bridge Street
    YO25 6DA Driffield
    The Chapel
    পরিচালক
    Bridge Street
    YO25 6DA Driffield
    The Chapel
    United KingdomBritishNone43436700003
    RAWSON, David Gordon
    Bridge Street
    YO25 6DA Driffield
    The Chapel
    পরিচালক
    Bridge Street
    YO25 6DA Driffield
    The Chapel
    EnglandBritishNone71946020002
    CANN, Stephen James
    The White House
    Clarke Lane
    SK11 0NE Langley
    Cheshire
    সচিব
    The White House
    Clarke Lane
    SK11 0NE Langley
    Cheshire
    BritishAccountant33849510007
    NAYLOR, Simon Harry
    5 Limetree Court
    Limetree Lane Bilton
    HU11 4EB Hull
    North Humberside
    সচিব
    5 Limetree Court
    Limetree Lane Bilton
    HU11 4EB Hull
    North Humberside
    British8972080001
    WEST, Melvyn Arthur
    59 Avocet Way
    YO15 3NT Bridlington
    East Riding Of Yorkshire
    সচিব
    59 Avocet Way
    YO15 3NT Bridlington
    East Riding Of Yorkshire
    BritishAccountant16860380001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    BERRYMAN, Beverly John
    Halfway House
    92 Fishpool Street
    AL3 4RX St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Halfway House
    92 Fishpool Street
    AL3 4RX St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishBusiness Executive36666480006
    BLYTH, Michael Leonard
    22 Cheyne Walk
    HU18 1BX Hornsea
    North Humberside
    পরিচালক
    22 Cheyne Walk
    HU18 1BX Hornsea
    North Humberside
    BritishAdministration And Production71946090001
    CANN, Stephen James
    The White House
    Clarke Lane
    SK11 0NE Langley
    Cheshire
    পরিচালক
    The White House
    Clarke Lane
    SK11 0NE Langley
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant33849510007
    HINDLE, David
    8 Wold View South
    YO25 7RR Driffield
    East Riding Of Yorkshire
    পরিচালক
    8 Wold View South
    YO25 7RR Driffield
    East Riding Of Yorkshire
    BritishOperations Manager16938260003
    PROCTER, Andrew Charles Travers
    Laburnum Farm Far Lane
    Bewholme
    YO25 8EA Driffield
    East Yorkshire
    পরিচালক
    Laburnum Farm Far Lane
    Bewholme
    YO25 8EA Driffield
    East Yorkshire
    United KingdomBritishSolicitor19744800001
    RAWSON, David Gordon
    28 Ashcourt Drive
    HU18 1HE Hornsea
    East Yorkshire
    পরিচালক
    28 Ashcourt Drive
    HU18 1HE Hornsea
    East Yorkshire
    EnglandBritishSales Marketing71946020002
    RAWSON, Noel David Frank
    The Old Chapel
    Harpham
    YO25 0GY Driffield
    East Riding Of Yorkshire
    পরিচালক
    The Old Chapel
    Harpham
    YO25 0GY Driffield
    East Riding Of Yorkshire
    BritishDirector28242790001
    SHAW, Adrian Lindsey
    13 Wednesday Market
    HU17 0DH Beverley
    North Humberside
    পরিচালক
    13 Wednesday Market
    HU17 0DH Beverley
    North Humberside
    BritishManaging Director47427780003
    TOWNSHEND, Bernard John
    98 Glebe Road
    CB1 4TA Cambridge
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    98 Glebe Road
    CB1 4TA Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director17449050001
    WALKER, Michael
    163 Sigston Road
    HU17 9PJ Beverley
    East Riding Of Yorkshire
    পরিচালক
    163 Sigston Road
    HU17 9PJ Beverley
    East Riding Of Yorkshire
    BritishProduct Development Manager16938270001
    WELLS, Ian Robert
    22 Chestnut Avenue
    YO25 7SH Driffield
    East Riding Of Yorkshire
    পরিচালক
    22 Chestnut Avenue
    YO25 7SH Driffield
    East Riding Of Yorkshire
    BritishCommercial Manager16938240001
    WEST, Melvyn Arthur
    59 Avocet Way
    YO15 3NT Bridlington
    East Riding Of Yorkshire
    পরিচালক
    59 Avocet Way
    YO15 3NT Bridlington
    East Riding Of Yorkshire
    BritishAccountant16860380001
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    PARK ROSE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 14/08/2001 and
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ আগ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ আগ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ আগ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুন, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 14/08/2001 and
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুন, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of admission (to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 14/08/2001)
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুন, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property known as or being land & building to the east of carnaby court and land at carnaby covert lane, carnaby, bridlington t/nos HS89244 HS203440. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুন, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 14/08/2001
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুন, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুন, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Development Commission
    ব্যবসায়
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ নভে, ১৯৯১
    অর্জিত হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings at sticks lane carnaby near bridlington humberside t/n's HS203440 and HS89244.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৩অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০৬ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৬ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯১
    অর্জিত হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property adjoining park rose pottery carnaby covert lane carnaby near bridlington humberside t/n HS203440.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Development Commission
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৩অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ২৮ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৮৪
    অর্জিত হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The sum of £75,000 and all other monies and liabilities
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property situate at carnaby covert lane carnaby near bridlington t/n HS89244.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Council for Small Industries in Rural Areas
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৩অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ২৮ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    PARK ROSE LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২০ জুল, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৯ নভে, ২০১৮ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John William Butler
    Maclaren House Skerne Road
    YO25 6PN Driffield
    East Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    Maclaren House Skerne Road
    YO25 6PN Driffield
    East Yorkshire
    Andrew James Nichols
    Maclaren House Skerne Road
    YO25 6PN Driffield
    East Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    Maclaren House Skerne Road
    YO25 6PN Driffield
    East Yorkshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0