YORKSHIRE BUILDING SUPPLIES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামYORKSHIRE BUILDING SUPPLIES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02619556
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    YORKSHIRE BUILDING SUPPLIES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    YORKSHIRE BUILDING SUPPLIES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Portland House Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    YORKSHIRE BUILDING SUPPLIES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    YORKSHIRE BUILDING SUPPLIES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ১২ জুন, ২০১৭ তারিখে Mr Michael John Choules-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৪ মে, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠা4.71

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৯ সেপ, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    ১৫ আগ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Tarmac Directors (Uk) Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ জুন, ২০১৬

    ০৯ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    ০১ জুন, ২০১৬ তারিখে Mr Michael John Choules-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৫ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Fiona Puleston Penhallurick এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ১৪ ডিসে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Lafarge Tarmac Directors (Uk) Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৭ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Michael John Choules-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ আগ, ২০১৫ তারিখে Lafarge Tarmac Secretaries (Uk) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ জুন, ২০১৫

    ১৪ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 82,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ জুন, ২০১৪

    ১০ জুন, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 82,000
    SH01

    ২৮ জুন, ২০১৩ তারিখে Lafarge Secretaries (Uk) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    পরিচালক হিসাবে Andrew Bolter এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mrs Fiona Puleston Penhallurick-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    YORKSHIRE BUILDING SUPPLIES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    TARMAC SECRETARIES (UK) LIMITED
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর532256
    9859690020
    CHOULES, Michael John
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    পরিচালক
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United KingdomBritishAccountant178681090003
    TARMAC DIRECTORS (UK) LIMITED
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর3221775
    148616660003
    DOUGLAS, Helen
    3 Thorngrove Drive
    SK9 1DQ Wilmslow
    Cheshire
    সচিব
    3 Thorngrove Drive
    SK9 1DQ Wilmslow
    Cheshire
    British93893410001
    JONES, Ann
    Forge Cottage 57 High Street
    Braithwell
    S66 7AW Rotherham
    South Yorkshire
    সচিব
    Forge Cottage 57 High Street
    Braithwell
    S66 7AW Rotherham
    South Yorkshire
    British13687950001
    ROBINSON, Mark Russell
    53 Rectory Street
    Epworth
    DN9 1HX Doncaster
    South Yorkshire
    সচিব
    53 Rectory Street
    Epworth
    DN9 1HX Doncaster
    South Yorkshire
    British94894160001
    TARMAC NOMINEES TWO LIMITED
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    C/O Tarmac Plc
    West Midlands
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    C/O Tarmac Plc
    West Midlands
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর3782704
    68229150002
    BAKER, Stewart Anthony
    1 Home Farm Cottages
    Serlby
    DN10 6BA Doncaster
    পরিচালক
    1 Home Farm Cottages
    Serlby
    DN10 6BA Doncaster
    BritishSales Director61488940002
    BOLTER, Andrew Christopher
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant146583270001
    CLARE, Kenneth Stephen
    5 Gleneagles Drive
    Tytherington
    SK10 2TG Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    5 Gleneagles Drive
    Tytherington
    SK10 2TG Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Director13078410002
    DICKINSON, Paul Michael
    11 Sadler Copse
    Adel
    LS16 8NW Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    11 Sadler Copse
    Adel
    LS16 8NW Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant43277940001
    GRADY, David Anthony
    Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NR Birmingham
    20
    পরিচালক
    Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NR Birmingham
    20
    EnglandBritishAccountant139324790001
    GRIMASON, Deborah
    Bickenhill Lane
    B37 7BQ Solihuill
    Portland House
    West Midlands
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bickenhill Lane
    B37 7BQ Solihuill
    Portland House
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor120668330001
    JAMES, Clive Cadwgan
    Hillcote Cottage
    1 Jeffrey Lane Bradwell
    S33 9JE Sheffield
    পরিচালক
    Hillcote Cottage
    1 Jeffrey Lane Bradwell
    S33 9JE Sheffield
    BritishManaging Director45777800003
    JONES, Mark David
    The Oaks
    23 Warning Tongue Lane
    DN4 6TB Bessacarr
    South Yorkshire
    পরিচালক
    The Oaks
    23 Warning Tongue Lane
    DN4 6TB Bessacarr
    South Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director13687960005
    LATIBEAUDIERE, Andrea Jayne
    16 Lindrick Drive
    Armthorpe
    DN3 3SQ Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    16 Lindrick Drive
    Armthorpe
    DN3 3SQ Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishAccounts Director54255610001
    PENHALLURICK, Fiona Puleston
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director147397910001
    ROBINSON, Mark Russell
    53 Rectory Street
    Epworth
    DN9 1HX Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    53 Rectory Street
    Epworth
    DN9 1HX Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director94894160001
    STIRK, James Richard
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    West Midlands
    পরিচালক
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritishSolicitor34328400002
    WILLIAMS, Trevor
    171 High Street
    Dunsville
    DN7 4BU Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    171 High Street
    Dunsville
    DN7 4BU Doncaster
    South Yorkshire
    BritishDirector81085000001
    WOOD, Nicholas Henry Aldous
    44 Whitmore Road
    Westlands
    ST5 3LX Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    পরিচালক
    44 Whitmore Road
    Westlands
    ST5 3LX Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    BritishCompany Director105085320001
    LAFARGE TARMAC DIRECTORS (UK) LIMITED
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর3221775
    148616660002
    TARMAC NOMINEES LIMITED
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    C/O Tarmac Plc
    West Midlands
    কর্পোরেট পরিচালক
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    C/O Tarmac Plc
    West Midlands
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর670096
    68229260001
    TARMAC NOMINEES TWO LIMITED
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    C/O Tarmac Ltd
    West Midlands
    England
    কর্পোরেট পরিচালক
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    C/O Tarmac Ltd
    West Midlands
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর3782704
    127793500001

    YORKSHIRE BUILDING SUPPLIES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মPrivate Company Limited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর453791
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    YORKSHIRE BUILDING SUPPLIES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold property known as or being land and buildings lying to the north of bawtry road harworth doncaster title number NT24832. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ মে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জানু, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ জানু, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ মে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the west side of plumtree industrial estate harworth doncaster south yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Donbac Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the west side of plumtree road plumtree industrial estate harworth doncaster south yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Donbac Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land on the south west side of plumtree road plumtree industrial estate harworth doncaster south yorkshire t/no.NT242014. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ মে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ এপ্রি, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a land on the south west side of plumtree road plumtreet industrial estate harworth doncaster t/n NT242014. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a land on the south-west side of plumtree road plumtree industrial estate harworth doncaster south yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Donbac Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the south west side of plumtree road harworth nottinghamshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £40,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over and book debts. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Donbac Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ মার্চ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    YORKSHIRE BUILDING SUPPLIES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৯ সেপ, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৪ আগ, ২০১৭ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0