PRIMAL PICTURES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPRIMAL PICTURES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02622298
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PRIMAL PICTURES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • শিল্প সৃষ্টি (90030) / কলা, বিনোদন এবং বিনোদন

    PRIMAL PICTURES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PRIMAL PICTURES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    OBTAINTIME LIMITED২০ জুন, ১৯৯১২০ জুন, ১৯৯১

    PRIMAL PICTURES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    PRIMAL PICTURES LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    PRIMAL PICTURES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ০৮ অক্টো, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Reduction of share premium account 01/10/2014
    RES13

    ২৪ সেপ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Laurence Michael Wiseman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    ০৭ ফেব, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Emily Louise Martin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ৩১ ডিসে, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter Stephen Rigby এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ ডিসে, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Adam Christopher Walker এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ নভে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,324,376
    5 পৃষ্ঠাSH02

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    38 পৃষ্ঠাMEM/ARTS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01

    ১০ আগ, ২০১২ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,552,591.0
    6 পৃষ্ঠাSH01

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    14 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    ০৩ জুন, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter Wishart Allan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ জুন, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Janet Johnston এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ জুন, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nicholas Ernest Del Rio এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ মার্চ, ২০১৩ তারিখে Mr Adam Christopher Walker-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    ২১ অক্টো, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে David John Carman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    39 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    PRIMAL PICTURES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WOOLLARD, Julie Louise
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    সচিব
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    171860860001
    HOPLEY, Rupert John Joseph
    6300 Zug
    Gubelstrasse 11
    Switzerland
    পরিচালক
    6300 Zug
    Gubelstrasse 11
    Switzerland
    SwitzerlandBritishSolicitor164632060002
    WRIGHT, Gareth Richard
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    পরিচালক
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritishAccountant131115190002
    GARDNER, Steven Mark
    Flat 38 Craig House
    Hartington Road Ealing
    W13 8QJ London
    সচিব
    Flat 38 Craig House
    Hartington Road Ealing
    W13 8QJ London
    British84547910001
    HANSFORD, Derek Bernard
    Stanley Mills
    GL10 3HQ Stonehouse
    Glos
    সচিব
    Stanley Mills
    GL10 3HQ Stonehouse
    Glos
    British50933660002
    JOHNSTON, Janet
    Floor Tennyson House
    159-163 Great Portland Street
    W1W 5PA London
    4th
    সচিব
    Floor Tennyson House
    159-163 Great Portland Street
    W1W 5PA London
    4th
    BritishChartered Accountant115531480001
    MANNING, Arlene Christina
    Stanley Mills
    GL10 3HQ Stonehouse
    Glos
    সচিব
    Stanley Mills
    GL10 3HQ Stonehouse
    Glos
    British14650290001
    MARTIN, Emily Louise
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    সচিব
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    171915210001
    WISEMAN, Laurence Michael
    47 Heath Hurst Road
    NW3 2RU London
    সচিব
    47 Heath Hurst Road
    NW3 2RU London
    British10265410003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALLAN, Peter Wishart
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    পরিচালক
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director13690240001
    BELL, David Allan
    Chandos Place
    Covent Garden
    WC2N 4HS London
    53
    United Kingdom
    পরিচালক
    Chandos Place
    Covent Garden
    WC2N 4HS London
    53
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Manager146053310001
    BRISCOE, Christopher
    25 Cross Street
    N1 2BH London
    পরিচালক
    25 Cross Street
    N1 2BH London
    EnglandBritishComputer Graphics Director14373900001
    CAMERON, Ian Fergus
    St. Thomas Street
    SE1 9RS London
    New City Court
    England
    পরিচালক
    St. Thomas Street
    SE1 9RS London
    New City Court
    England
    EnglandBritishInvestment Director154321030001
    CAMMERMAN, Philip Simon
    55 The Fairway
    Alwoodley
    LS17 7PE Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    55 The Fairway
    Alwoodley
    LS17 7PE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director2607800001
    CARMAN, David John
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    পরিচালক
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector64618620001
    GARDNER, Steven Mark
    Flat 38 Craig House
    Hartington Road Ealing
    W13 8QJ London
    পরিচালক
    Flat 38 Craig House
    Hartington Road Ealing
    W13 8QJ London
    EnglandBritishChartered Accountant84547910001
    GRAY, Timothy John
    13 Lymington Road
    NW6 1HX London
    পরিচালক
    13 Lymington Road
    NW6 1HX London
    BritishDirector84547770001
    HANSFORD, Derek Bernard
    Stanley Mills
    GL10 3HQ Stonehouse
    Glos
    পরিচালক
    Stanley Mills
    GL10 3HQ Stonehouse
    Glos
    BritishAccountant50933660002
    JOHNSTON, Janet
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    পরিচালক
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant180248340001
    JONES, Nicholas Dann
    92 Abbeville Road
    SW4 9NA London
    পরিচালক
    92 Abbeville Road
    SW4 9NA London
    BritishBanker75348450001
    MAJNONI D INTIGNANO, Antoine Georges Aviel
    29 Boulevard Du Couchaut
    92 000
    Nanterres
    France
    পরিচালক
    29 Boulevard Du Couchaut
    92 000
    Nanterres
    France
    FrenchDirector Of Distressed Asset88575400001
    NEAL, Stephen Bryan
    5 Acer Avenue
    TN2 5JQ Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    5 Acer Avenue
    TN2 5JQ Tunbridge Wells
    Kent
    BritishPublisher23978960001
    RIGBY, Peter Stephen
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    পরিচালক
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritishCompany Director69164290007
    RIO, Nicholas Ernest Del
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    পরিচালক
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    United StatesEnglishCompany Director172166990001
    WALKER, Adam Christopher
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    পরিচালক
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritishFinance Director129368430003
    WHITE, Michael
    Old School House
    Wreaks Road, Birstwith
    HG3 2NJ Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Old School House
    Wreaks Road, Birstwith
    HG3 2NJ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishInvestment Director69358900001
    WISEMAN, Laurence Michael
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    পরিচালক
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    United KingdomBritishProducer10265410003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    PRIMAL PICTURES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মে, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মে, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposited sum being £30,466.60. see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mount Eden Land Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ মে, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposited sum being the sum of £29,347.50 placed in a separately designated deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mount Eden Land Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company's interest in the deposit account (in which the sum of £47,000 has initially been placed) and all money withdrawn from it.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mount Cook Land Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Enterprise Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ফেব, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুন, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit sum (£74,250) plus vat thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mount Cook Land Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ জুন, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £28,365.68.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Consumer Credit Trade Association
    ব্যবসায়
    • ১৮ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুন, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ ফেব, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0