EBS NOMINEES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামEBS NOMINEES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02651363
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    EBS NOMINEES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7487) /

    EBS NOMINEES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    2 Broadgate
    London
    EC2M 7UR
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    EBS NOMINEES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TRUSHELFCO (NO.1746) LIMITED০৪ অক্টো, ১৯৯১০৪ অক্টো, ১৯৯১

    EBS NOMINEES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০০৯

    EBS NOMINEES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পরিচালক হিসাবে Samantha Anne Wren-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Iain Torrens এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ অক্টো, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ অক্টো, ২০১০

    ১৪ অক্টো, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ অক্টো, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ১৩ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Deborah Anne Abrehart-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০৬ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Iain William Torrens-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৬ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Deborah Anne Abrehart-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    EBS NOMINEES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ABREHART, Deborah Anne
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    সচিব
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    BritishChartered Secretary3219400009
    ABREHART, Deborah Anne
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    পরিচালক
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    United KingdomBritishChartered Secretary3219400009
    WREN, Samantha Anne
    Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    পরিচালক
    Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    EnglandBritishCorporate Treasurer155853230001
    FORSTER, Jane
    56 Wavertree Road
    SW2 3SS London
    সচিব
    56 Wavertree Road
    SW2 3SS London
    British44284390003
    FORSTER, Jane
    56 Wavertree Road
    SW2 3SS London
    সচিব
    56 Wavertree Road
    SW2 3SS London
    British44284390003
    MANDRYKO, Erica Nadia
    75 Silverthorne Road
    Battersea
    SW8 3HH London
    সচিব
    75 Silverthorne Road
    Battersea
    SW8 3HH London
    British108502750001
    SCOULLAR, Kathryn Charlotte
    104 Acacia Road
    E17 8BW London
    সচিব
    104 Acacia Road
    E17 8BW London
    British97716910002
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    BARTKO, Peter
    26 Burgess Hill
    Cricklewood
    NW2 2DA London
    পরিচালক
    26 Burgess Hill
    Cricklewood
    NW2 2DA London
    AmericanBanker25724130001
    CAPLEN, Stephen Gerard
    21 Saxon Road
    SO23 7DJ Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    21 Saxon Road
    SO23 7DJ Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritishHead Of Finance97716670001
    CASS, Trevor Norman
    Mount Avenue
    SS0 8PT Westcliff On Sea
    38
    Essex
    পরিচালক
    Mount Avenue
    SS0 8PT Westcliff On Sea
    38
    Essex
    United KingdomBritishBank Director24679090001
    CHANDLER, Christine Anne
    31 Chesnut Grove
    New Malden
    Surrey
    মনোনীত পরিচালক
    31 Chesnut Grove
    New Malden
    Surrey
    British900007180001
    FROST-SMITH, Paul
    Flat B 58 Arundel Square
    N7 8AP London
    পরিচালক
    Flat B 58 Arundel Square
    N7 8AP London
    BritishSolicitor13601240001
    JEFFERY, Jonathan Joseph
    10 The Quillot
    Burwood Park
    KT12 5BY Walton On Thames
    পরিচালক
    10 The Quillot
    Burwood Park
    KT12 5BY Walton On Thames
    EnglandBritishChief Executive Officer190841020001
    KIDD, Timothy Charles
    Wolmer Cottage
    Frieth Road
    SL7 2JQ Marlow
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Wolmer Cottage
    Frieth Road
    SL7 2JQ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector117842820001
    LEDSHAM, David Anthony
    145 Bradbourne Park Road
    TN13 3LB Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    145 Bradbourne Park Road
    TN13 3LB Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishChief Financial Officer22759190001
    MANION, Kevin Patrick
    26 Mayflower Parkway
    IRISH Westport
    Ct 06880. 6014
    Usa
    পরিচালক
    26 Mayflower Parkway
    IRISH Westport
    Ct 06880. 6014
    Usa
    AmericanChief Financial Officer71401310002
    MORAN, William Loyola
    38 Braunview Way
    Orchard Park
    14127 New York
    Usa
    পরিচালক
    38 Braunview Way
    Orchard Park
    14127 New York
    Usa
    AmericanChief Operating Officer68336410001
    REEVE, Robert Arthur
    6 Wellesford Close
    SM7 2HL Banstead
    Surrey
    মনোনীত পরিচালক
    6 Wellesford Close
    SM7 2HL Banstead
    Surrey
    British900007190001
    SAUNDERS, Christopher John
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    পরিচালক
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    BritishSolicitor21044340001
    SINGH, Jasbir
    28 Fairholme Road
    West Kensington
    W14 9JX London
    পরিচালক
    28 Fairholme Road
    West Kensington
    W14 9JX London
    BritishBanker50876200001
    TORRENS, Iain William
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    পরিচালক
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    EnglandBritishChartered Accountant120015110001
    YOSHIDA, Rodney Neal
    104 Arboresque Drive
    New Hope
    Pennsylvania 18938
    Usa
    পরিচালক
    104 Arboresque Drive
    New Hope
    Pennsylvania 18938
    Usa
    AmericanFinance Director69659420002

    EBS NOMINEES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement (governed by the laws of the state of new york)
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrowers (as defined) to the chargee under the facilities agreement and all present and future obligations of the company to the chargee under the security agreement, the composite guarantee (as defined) and under each other agreement and instrument referred to in the facilities agreement to which the company is a party
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The pledged stock, the stock collateral, accounts, instruments, inventory, equipment etc. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Investment Bank Limited (As Trustee for the Beneficiaries)(Since Re-Named Chase Manhattan International Limited)
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security agreement (intellectual property; japan)
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Any and all obligations from time to time of the company to the chargee under the composite guarantee (as defined) and the security agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights title and interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Investment Bank Limited (As Trustee for the Beneficiaries)(Since Re-Named Chase Manhattan International Limited)
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite debenture (singapore) (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Investment Bank Limited (As Trustee for the Beneficiaries)(Since Re-Named Chase Manhattan International Limited)
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite debenture (hong kong) (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Investment Bank Limited (As Trustee for the Beneficiaries)(Since Re-Named Chase Manhattan International Limited)
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite debenture (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Investment Bank Limited (As Trustee for the Beneficiaries)(Since Re-Named Chase Manhattan International Limited)
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0