BRITTON GROUP PLASTICS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBRITTON GROUP PLASTICS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02659844
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BRITTON GROUP PLASTICS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    BRITTON GROUP PLASTICS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BRITTON GROUP PLASTICS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TACO HOLDINGS LIMITED৩০ এপ্রি, ১৯৯২৩০ এপ্রি, ১৯৯২
    SCHEMEPREFER LIMITED০৪ নভে, ১৯৯১০৪ নভে, ১৯৯১

    BRITTON GROUP PLASTICS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ এপ্রি, ২০১২

    BRITTON GROUP PLASTICS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01
    A1MZR4ZK

    ০৫ নভে, ২০১২ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,154,656.50
    4 পৃষ্ঠাSH01
    A1MCP7RN

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04
    R1MDUNEP

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    X1ITUGCX

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA
    A1DV262G

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    XYGDBY41

    পরিচালক হিসাবে Michael Clark এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01
    XLU4NX44

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA
    ASOO5VYC

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ অক্টো, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    XM8HUO6W

    ০৬ নভে, ২০০৯ তারিখে Michael Clark-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XM8HTO6V

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA
    A2T1ULPA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ অক্টো, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    XJAASDX2

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Stephen Tony Goodman-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XJAARDX1

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Michael Clark-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XJAAQDX0

    হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA
    ACCK7AGF

    হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA
    A06SN7BD

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a
    XW9PV3QF

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    BRITTON GROUP PLASTICS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    সচিব
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director42598360003
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    UkBritishCompany Director42598360003
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    সচিব
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    BritishGroup Controller94622690001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    সচিব
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    BritishAccountant89866330001
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    সচিব
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    BritishAccountant78877930001
    MOLE, Stephen Richard
    Moor Lane
    Woodford
    SK7 1PW Stockport
    55
    Cheshire
    সচিব
    Moor Lane
    Woodford
    SK7 1PW Stockport
    55
    Cheshire
    BritishFinance Director24121400002
    OGDEN, Nicholas Michael
    17 Park Row
    Heaton Mersey
    SK4 3DY Stockport
    Cheshire
    সচিব
    17 Park Row
    Heaton Mersey
    SK4 3DY Stockport
    Cheshire
    British18614170001
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    সচিব
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    British73033280001
    SMITH, Andrew John
    Flat A 28-30 Kings Road
    Wimbledon
    SW19 8QW London
    সচিব
    Flat A 28-30 Kings Road
    Wimbledon
    SW19 8QW London
    British65907810002
    TAYLOR, Mark Jonathan
    5 Tarvin Close
    SK11 7JJ Macclesfield
    Cheshire
    সচিব
    5 Tarvin Close
    SK11 7JJ Macclesfield
    Cheshire
    British50778530001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEART, Simon Delaval
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    পরিচালক
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    BritishAccountant28376970001
    BEAUMONT, Nigel Peter
    56 Church Street
    LU7 1BT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    পরিচালক
    56 Church Street
    LU7 1BT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishExecutive95868800001
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    পরিচালক
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    EnglandBritishGroup Controller94622690001
    BURNHAM, Jedidiah James
    3785 South Valley Drive
    80439 Evergreen
    Colorado
    Usa
    পরিচালক
    3785 South Valley Drive
    80439 Evergreen
    Colorado
    Usa
    AmericanExecutive56560680001
    CLARK, Michael
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    পরিচালক
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    EnglandBritishDirector92294570002
    CONSTANCIO, Gail Ann
    2795 Berry Circle
    80401 Golden
    Colorado
    Usa
    পরিচালক
    2795 Berry Circle
    80401 Golden
    Colorado
    Usa
    AmericanExecutive55754050001
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    পরিচালক
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    UkBritishAccountant78877930001
    MILLICAN, Keith
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    পরিচালক
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    BritishChief Financial Officer59839640001
    PARISH, Beth Anne
    10726 W Evans
    80227 Lakewood
    Colorado
    Usa
    পরিচালক
    10726 W Evans
    80227 Lakewood
    Colorado
    Usa
    UsaExecutive55754140001
    PETERS, Raymond Albert
    12 Shearwater Close
    LN6 0XU Lincoln
    Lincolnshire
    পরিচালক
    12 Shearwater Close
    LN6 0XU Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishExecutive70111470001
    SAMUEL, Paul Richard Belock
    Moss Cottage Moss Lane
    Tiverton Heath
    CW6 Tarporley
    Cheshire
    পরিচালক
    Moss Cottage Moss Lane
    Tiverton Heath
    CW6 Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director16754410001
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    পরিচালক
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    EnglandBritishDirector73033280001
    SELINSKE, Steven
    23834 Village Blacksmith
    TX 78255 San Antonio
    Usa
    পরিচালক
    23834 Village Blacksmith
    TX 78255 San Antonio
    Usa
    AmericanExecutive Vice President57338010001
    SISSON, Jill Bartlett Woodman
    5808 Crestbrook Circle
    80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    পরিচালক
    5808 Crestbrook Circle
    80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    AmericanGeneral Counsel56560720001
    SMITH, Colin Alfred
    39 Aberdeen Park
    Highbury
    N5 2AR London
    পরিচালক
    39 Aberdeen Park
    Highbury
    N5 2AR London
    EnglandBritishDirector66857520002
    TAYLOR, Mark Jonathan
    5 Tarvin Close
    SK11 7JJ Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    5 Tarvin Close
    SK11 7JJ Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Director50778530001
    TAYLOR, Michael John
    Stapleford Cottage
    Stapleford
    CW6 0ET Tarporley
    Cheshire
    পরিচালক
    Stapleford Cottage
    Stapleford
    CW6 0ET Tarporley
    Cheshire
    BritishCompany Director16882280001
    WARD, Justin Paul
    53 Saint Johns Avenue
    SW15 6AL London
    পরিচালক
    53 Saint Johns Avenue
    SW15 6AL London
    BritishExecutive78777110002
    WATTERS, Roderick Ian Alistair
    The Mill
    Mill Lane
    RG9 4HB Henley On Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    The Mill
    Mill Lane
    RG9 4HB Henley On Thames
    Oxfordshire
    AustralianExecutive67175860001
    WHITBY, Andrew John
    3 Owens Road
    SO22 6RU Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    3 Owens Road
    SO22 6RU Winchester
    Hampshire
    BritishOperations Director39928640001
    WHITTAKER, Peter Gordon
    58 Kings Court
    Kings Drive
    HA9 9JQ Wembley
    Middlesex
    পরিচালক
    58 Kings Court
    Kings Drive
    HA9 9JQ Wembley
    Middlesex
    BritishExecutive58201840001
    WHITWORTH, Anthony Elliott
    Highfield House
    Peover Lane Chelford
    SK11 9AW Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    Highfield House
    Peover Lane Chelford
    SK11 9AW Macclesfield
    Cheshire
    BritishBompa Non - Executive Director54616890001
    WIGHTMAN, Sally
    11 St Jamess Square
    M2 6DR Manchester
    Lancashire
    পরিচালক
    11 St Jamess Square
    M2 6DR Manchester
    Lancashire
    BritishSolicitor41935720001

    BRITTON GROUP PLASTICS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A guarantee and debenture made between the companies listed on the shedule attached to the form 395 (together the "charging companies"), the chargee and the cvc entities named therein
    তৈরি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Each of the charging companies has covenanted and guaranteed that it will on demand in writing made to it by the noteholders in accordance with the terms of the loan note instrument pay to the subordinated security agent for the account of each of the beneficiaries all moneys obligations and liabilities which shall for the time being be due from owing or incurred by it or by any other group company (including any other company) to each of the noteholders under the loan note instrument and whether on or after such demand whether actually or contingently whether solely or jointly with any other person whether as principal or surety and whether or not the relevant beneficiary was an original party to the relevant transaction including all interest commission fees charges costs and expenses which each beneficiary may in the course of its business charge or incur in respect of any company or its affairs and so that interest shall be computed and compounded in accordance with the loan note instrument (after as well as before any demand or judgment)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Properties as listed on the schedule attached to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse First Boston as Subordinated Security Agent for and on Behalf of the Beneficiaries (As Defined Therein)
    ব্যবসায়
    • ১৯ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the senior finance documents and the mezzanine finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse First Boston,as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৬ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0