QSR SPORTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামQSR SPORTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02663764
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    QSR SPORTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    QSR SPORTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    440-450 Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    Northamptonshire
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    QSR SPORTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    QUASERSPORT LIMITED১৩ জানু, ১৯৯২১৩ জানু, ১৯৯২
    BRIGHT TASK LIMITED১৮ নভে, ১৯৯১১৮ নভে, ১৯৯১

    QSR SPORTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৬ ফেব, ২০১১

    QSR SPORTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ০৩ ফেব, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Mark Derrick Beacham এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৩ ফেব, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Julia Reynolds এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ ফেব, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Dominic Joseph Lavelle এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ ফেব, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark Derrick Beacham এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৬ ডিসে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Marcello Lombardo এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২১ নভে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Dominic Joseph Lavelle-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৬ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Ms Julia Reynolds-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ জুন, ২০১১

    ১৫ জুন, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,888,693
    SH01

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    39 পৃষ্ঠাMA

    পরিচালক হিসাবে Mr Mark Derrick Beacham-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Richard Hitt এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01

    ০৫ নভে, ২০১০ তারিখে শেয়ার একত্রীকরণ

    9 পৃষ্ঠাSH02

    শেয়ার শ্রেণীর নাম বা পদবী পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাSH08

    শেয়ারের সাথে সংযুক্ত অধিকারের পরিবর্তনের বিবরণ

    2 পৃষ্ঠাSH10

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    40 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    শেয়ারের অধিকার বা নাম পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES12
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৭ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Mark Derrick Beacham-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Marcello Lombardo-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Richard John Hitt-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    QSR SPORTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BEACHAM, Mark Derrick
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    সচিব
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    British135313320001
    BENNETT, Terry
    Randolph Avenue
    W9 1BG London
    72d
    সচিব
    Randolph Avenue
    W9 1BG London
    72d
    British135196530001
    DAWSON, Mary Louise
    57 Elms Road
    SW4 9EP London
    সচিব
    57 Elms Road
    SW4 9EP London
    British68983920002
    HOLDSWORTH, Cheryl Irene
    26 Chelveston
    AL7 2PW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    সচিব
    26 Chelveston
    AL7 2PW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British48354260001
    MURRAY, Philip John
    44 Hauxley Drive
    Waldridge Park
    DH2 3TE Chester Le Street
    County Durham
    সচিব
    44 Hauxley Drive
    Waldridge Park
    DH2 3TE Chester Le Street
    County Durham
    BritishGroup Finance Manager79329620001
    O'KEEFFE, Mark John
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    সচিব
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    British57880430001
    PILLAY, Paul Vijayasingam
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    সচিব
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    OtherHead Of Finance & Company Secr79416150001
    PLANT, William Allan
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    সচিব
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    British87465680001
    WILKINSON, John Richard
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    সচিব
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director2545190001
    RUTLAND DIRECTORS LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005280001
    SECRETARIES BY DESIGN LIMITED
    Blackthorn House Mary Ann Street
    St Pauls Square
    B3 1RL Birmingham
    কর্পোরেট সচিব
    Blackthorn House Mary Ann Street
    St Pauls Square
    B3 1RL Birmingham
    34964180001
    BEACHAM, Mark Derrick
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    পরিচালক
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritishCompany Secretary160095260001
    BENNETT, Paul David
    The Manor House
    Exelby
    DL8 2HB Bedale
    North Yorkshire
    পরিচালক
    The Manor House
    Exelby
    DL8 2HB Bedale
    North Yorkshire
    BritishCompany Director49486180001
    BENNINGTON, Glenn Martin
    7 Hartburn Avenue
    Hartburn
    TS18 4ES Stockton On Tees
    Cleveland
    পরিচালক
    7 Hartburn Avenue
    Hartburn
    TS18 4ES Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director39700130001
    BENTLEY, Simon Anthony
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    পরিচালক
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    United KingdomBritishCompany Director3007630001
    CRAWFORD, Peter
    1 Tudhoe Hall Farm Court
    Tudhoe Village
    DL16 6LB Spennymoor
    County Durham
    পরিচালক
    1 Tudhoe Hall Farm Court
    Tudhoe Village
    DL16 6LB Spennymoor
    County Durham
    EnglandBritishManaging Director95758680001
    CROSLAND, Roy Nicholson
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    পরিচালক
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    BritishDirector30882970002
    EVANS, Graham Rees
    107 Rye Street
    CM23 2HD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    107 Rye Street
    CM23 2HD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSales & Marketing26190440001
    FLEMING, Keith
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    পরিচালক
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishDirector112723440002
    GIDNEY, Simon Mark
    The Old Castle
    B80 7AD Studley
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Old Castle
    B80 7AD Studley
    Warwickshire
    BritishDirector6775840002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director30306840002
    HARDY, Russell Stephen Mons
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritishChief Executive45844210003
    HARTLEY, Peter Christopher
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    পরিচালক
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    United KingdomBritishFinance Director96458190001
    HITT, Richard John
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    পরিচালক
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritishBusiness Analyst & Insight127468180001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    পরিচালক
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritishFinance Director137285750001
    LOMBARDO, Marcello
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    পরিচালক
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritishFinance Director135699240001
    MALONE, Desmond Philip
    1 Morpeth
    B77 1JF Tamworth
    Staffordshire
    পরিচালক
    1 Morpeth
    B77 1JF Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector87170450001
    PLANT, William Allan
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    পরিচালক
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    BritishCompany Director87465680001
    REYNOLDS, Julia
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    পরিচালক
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritishChief Executive127468460001
    RUSSELL, David Arthur George
    6 Fernhill Crescent
    Stacksteads
    OL13 8JU Bacup
    Lancashire
    পরিচালক
    6 Fernhill Crescent
    Stacksteads
    OL13 8JU Bacup
    Lancashire
    BritishMerchandise Director54276750001
    SMITH, David Andrew Gordon
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director124619670001
    SPURLING, Anthony James
    Park Cottage 49 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JA St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Park Cottage 49 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JA St Albans
    Hertfordshire
    BritishCompany Director5224490001
    WILKINSON, John Richard
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinance Director2545190001
    NOMINEES BY DESIGN LIMITED
    Blackthorn House Mary Ann Street
    St Pauls Square
    Birmingham
    West Midlands
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Blackthorn House Mary Ann Street
    St Pauls Square
    Birmingham
    West Midlands
    900005710001

    QSR SPORTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Chartered Bank
    ব্যবসায়
    • ১৬ মার্চ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0