BMS CORP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBMS CORP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02682894
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BMS CORP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7487) /

    BMS CORP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    8 Hanover Street
    W1S 1YE London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BMS CORP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BRADMAN MANAGEMENT SERVICES LIMITED২৭ জানু, ১৯৯২২৭ জানু, ১৯৯২

    BMS CORP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০০৮

    BMS CORP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    উইন্ডিং আপের সমাপ্তি

    1 পৃষ্ঠাL64.07

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    2 পৃষ্ঠাCOCOMP

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS16(SOAS)

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    বার্ষিক রিটার্ন ২৭ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    14 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ জুন, ২০১০

    ১৪ জুন, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 15,087,498
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    সচিব হিসাবে Mohammad Khokhar এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed bradman management services LIMITED\certificate issued on 15/03/10
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৮ ফেব, ২০১০

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাCONNOT

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS16(SOAS)

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা88(2)R

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    7 পৃষ্ঠাMA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    প্রাক-স্বীকৃতি অধিকার বাতিলের রেজুলেশন

    RES11

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    BMS CORP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRADMAN, Godfrey Michael
    Berkeley Street
    W1J 8DJ London
    1
    পরিচালক
    Berkeley Street
    W1J 8DJ London
    1
    EnglandBritishCompany Director2068500003
    BALDWIN, Farah
    The Old Stores
    Westwell
    TN25 4LQ Ashford
    Kent
    সচিব
    The Old Stores
    Westwell
    TN25 4LQ Ashford
    Kent
    British70577150001
    KHOKHAR, Mohammad Irshad
    85 Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    সচিব
    85 Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    British2459860001
    MORKEL, Alan Gaunson
    Bramble Cottage 1 Churn Lane
    Horsmonden
    TN12 8HL Tonbridge
    Kent
    সচিব
    Bramble Cottage 1 Churn Lane
    Horsmonden
    TN12 8HL Tonbridge
    Kent
    British2068470001
    ALPHA SECRETARIAL LIMITED
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    900004510001
    ALPHA DIRECT LIMITED
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    900001400001

    BMS CORP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of subordination
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from challengerhold limited (the "borrower") to the chargee (the senior creditor) in any manner whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All present and future liabilities of the borrower to the company whatsoever the junior debt see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage of receipts
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and indebtedness due or to become due from the borrowers (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever ("liabilities")
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed equitable charge all and any monies together with all other sums or monies arising from the bms agreement. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Draypot Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage over shares
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and indebtedness due or to become due from the borrowers (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever ("liabilities")
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Legal mortgage over fully paid up shares together with all rights to dividends and other sums payable thereupon and all rights to take bonus shares or further shares. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Draypot Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility agreement dated 9 october 1997 or under or pursuant to the security documents (as defined in the facility agreement)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    36,564 ordinanry shares in aldeburgh limited together with all rights to ividends and other sums payable in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Draypot Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due from the company and/or european land & property corporation (kc & umds) limited to the chargee for the repayment of the shortfall (as therein defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The "deposit" being all sums standing to the credit of the account numbered 182260013 with the bank in the name of the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bankers Trust Company
    • Bti Investments
    • Ap Pelham Partners X Llc
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage of receipts
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement dated 9 october 1997 as supplemental or amended from time to time by any agreement in writing and/or the security documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed equitable charge all and any receipts (meaning all monies howsoever and any from the matters set out in the schedule attached to the 395 together with all other sums or monies arising from the bms agreement and deed of assignment and novation in relation to the matters referred to in the schedule hereto),. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Draypot Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Sub-mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The aggregate at any time of all monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and/or in connection with a facility agreement made on 9 october 1997 and any agreement,charge letter,mortgage guarantee,indemnity,or other instrument expressed to be issued or entered into pursuant or supplemental to it including monies or liabilities owing or due pursuant to the sub-mortgage and any other security documents or instruments from time to time granted or created in favour of the chargee under the facilityagreement (or any of them)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1.Legal mortgage and/or assigns to the chargee all the property and assets comprised in the charge of indemnities dated 9 october 1997.2.assigns the loan (as defined in the facility agreement of even date) and the benefit of all securities for the same.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Draypot Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the facility agreement of even date and/or the security documents (as defined in the facility agreement)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed equitable charge all and any receipts whether payable to or receivable by the company or any agent or other person on its behalf. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Draypot Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title benefit and interest in and to the contractbeing the management agreement dated 28 july 1995 including all monies, proceeds and other benefits of any kind. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Singer and Friedlander Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    BMS CORP LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৩ এপ্রি, ২০১৪ভেঙে গেছে
    ২০ নভে, ২০০৯আবেদন তারিখ
    ২১ জানু, ২০১৪ওয়াইন্ডিং আপ শেষ
    ১৫ ডিসে, ২০১০ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    বাধ্যতামূলক তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    অভ্যাসকারী
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0