MOWLEM TECHNICAL SERVICES (HOLDINGS) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMOWLEM TECHNICAL SERVICES (HOLDINGS) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02690390
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MOWLEM TECHNICAL SERVICES (HOLDINGS) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    MOWLEM TECHNICAL SERVICES (HOLDINGS) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    24 Birch Street
    Wolverhampton
    WV1 4HY West Midlands
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MOWLEM TECHNICAL SERVICES (HOLDINGS) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DAUBNEY HOLDINGS LIMITED২৪ ফেব, ১৯৯২২৪ ফেব, ১৯৯২

    MOWLEM TECHNICAL SERVICES (HOLDINGS) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    MOWLEM TECHNICAL SERVICES (HOLDINGS) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    2 পৃষ্ঠাDS01

    ২১ মে, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Carillion Secretariat Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২১ মে, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Timothy Francis George-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ ফেব, ২০১২

    ২৪ ফেব, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000
    SH01

    ০১ ডিসে, ২০১১ তারিখে Mr Timothy Francis George-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ ডিসে, ২০১১ তারিখে Mr Lee James Mills-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    MOWLEM TECHNICAL SERVICES (HOLDINGS) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GEORGE, Timothy Francis
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    সচিব
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    169302520001
    GEORGE, Timothy Francis
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    পরিচালক
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    EnglandBritish24075160004
    MILLS, Lee James
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    পরিচালক
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish53951880001
    DAUBNEY, Dolores Kathleen Amy
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    Lincolnshire
    সচিব
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    Lincolnshire
    British54745100001
    DAUBNEY, Karen Ann
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    Lincolnshire
    সচিব
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    Lincolnshire
    British24064590001
    CARILLION SECRETARIAT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    কর্পোরেট সচিব
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    33743910002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DAUBNEY, Dolores Marlane
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    পরিচালক
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    British35791310001
    DAUBNEY, Dolores Kathleen Amy
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    Lincolnshire
    পরিচালক
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish54745100001
    DAUBNEY, Ernest Ralph
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    Lincolnshire
    পরিচালক
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    Lincolnshire
    British24064600001
    DAUBNEY, Ernest Ralph Stuart
    2 Nashs Row
    Osgodby
    LN8 3TA Market Rasen
    Lincolnshire
    পরিচালক
    2 Nashs Row
    Osgodby
    LN8 3TA Market Rasen
    Lincolnshire
    British35791320001
    DAUBNEY, Karen Ann
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    Lincolnshire
    পরিচালক
    15 Lodge Lane
    Nettleham
    LN2 2RS Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish24064590001
    DAUBNEY, Martin
    Stanton House Scothern Lane
    Sudbrooke
    LN2 2QJ Lincoln
    Lincolnshire
    পরিচালক
    Stanton House Scothern Lane
    Sudbrooke
    LN2 2QJ Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish24064580001
    DAY, Stephen John
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    পরিচালক
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    EnglandBritish59028300002
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish96596920001
    CARILLION MANAGEMENT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    কর্পোরেট পরিচালক
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    36778210004

    MOWLEM TECHNICAL SERVICES (HOLDINGS) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a bishops road outer circle drive lincoln t/no;-LL14023. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from R. daubney & co. Limited to the chargee on any account whatsoever and by the mortgagor whether now or in the future
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property at bishops road, outer circle road, lincoln being leasehold land and premises. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £98,000 and all other monies due from the company to the chargees
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land & premises lying to the west of outer circle road lincoln county of lincolnshire t/no LL14023.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ernest Ralph and Dolores Kathleen Amy Daubney
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0