COMMUNITY CARELINE SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCOMMUNITY CARELINE SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02692545
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    COMMUNITY CARELINE SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য পরিষেবা কার্যক্রম এন.ই.সি. (96090) / অন্যান্য পরিষেবা কার্যক্রম

    COMMUNITY CARELINE SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    COMMUNITY CARELINE SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    COMMUNITY CARE LINE SERVICES LIMITED১৭ আগ, ১৯৯২১৭ আগ, ১৯৯২
    RECALLUNIT LIMITED০২ মার্চ, ১৯৯২০২ মার্চ, ১৯৯২

    COMMUNITY CARELINE SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৪

    COMMUNITY CARELINE SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    COMMUNITY CARELINE SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০৪ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jeffrey Paul Flanagan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৪ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Patrick Walter Stirland-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৪ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Martin Staunton-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৪ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Julianne Baker-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ অক্টো, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Wayne Harold Felton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ অক্টো, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Rohit Mannan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০২ জুন, ২০১৪ তারিখে Mr Jeffrey Paul Flanagan-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ মে, ২০১৪

    ১৩ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 3,909
    SH01

    ২৭ মার্চ, ২০১৪ তারিখে Mr Jeffrey Paul Flanagan-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৭ মার্চ, ২০১৪ তারিখে Mr Wayne Harold Felton-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২০ জানু, ২০১৪ তারিখে Mitie Company Secretarial Services Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Mr Rohit Mannan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Dun এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে David Harland এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    13 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    পরিচালক হিসাবে Mr David Nicholas Harland-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mr Wayne Felton-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Mitie Company Secretarial Services Limited-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP04

    COMMUNITY CARELINE SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর01223825
    173215840001
    BAKER, Julianne
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    পরিচালক
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    United KingdomBritishDirector192429900001
    STAUNTON, Martin
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    পরিচালক
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    United KingdomBritishDirector192431160001
    STIRLAND, Patrick Walter
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    পরিচালক
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    United KingdomBritishDirector69756530007
    AYLMER, Susan Jane
    174 Pippin Street
    L40 7SP Burscough
    Lancashire
    সচিব
    174 Pippin Street
    L40 7SP Burscough
    Lancashire
    British79880200002
    AYLMER, Susan Jane
    73 Merscar Lane
    L40 9RL Scarisbrick
    Lancashire
    সচিব
    73 Merscar Lane
    L40 9RL Scarisbrick
    Lancashire
    BritishPrivate Domiciliary Service79880200001
    HEADLEY, Michael
    174 Pippin Street
    Burscough
    L40 7SP Ormskirk
    Lancashire
    সচিব
    174 Pippin Street
    Burscough
    L40 7SP Ormskirk
    Lancashire
    BritishDirector30560120002
    JACKSON, David
    9-11 Church Street West
    GU21 6DJ Woking
    First Floor Church Gate
    Surrey
    United Kingdom
    সচিব
    9-11 Church Street West
    GU21 6DJ Woking
    First Floor Church Gate
    Surrey
    United Kingdom
    BritishFinance Director280628560001
    MARSHALL, Tracy
    24 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3AD Birmingham
    West Midlands
    সচিব
    24 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3AD Birmingham
    West Midlands
    British23527760001
    ORME, Geoffrey Michael
    35 The Avenue
    ST15 8DG Stone
    Staffordshire
    সচিব
    35 The Avenue
    ST15 8DG Stone
    Staffordshire
    British74927190001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AYLMER, Gregory
    174 Pippin Street
    L40 7SP Burscough
    Lancashire
    পরিচালক
    174 Pippin Street
    L40 7SP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director65673250004
    AYLMER, Susan Jane
    174 Pippin Street
    L40 7SP Burscough
    Lancashire
    পরিচালক
    174 Pippin Street
    L40 7SP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director79880200002
    BOOTY, Stephen Martin
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    পরিচালক
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    EnglandBritishDirector147928010001
    CACKETT, Barry John Alan
    45 Ashdown Close
    PR8 6TL Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    45 Ashdown Close
    PR8 6TL Southport
    Merseyside
    BritishDirector54046420001
    CLANCY, John Michael
    24 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3AD Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    24 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3AD Birmingham
    West Midlands
    BritishArticled Clerk55639710001
    DUN, Andrew Frederick
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    পরিচালক
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    United KingdomBritishChief Executive Officer85855780002
    FELTON, Wayne Harold
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    পরিচালক
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    United KingdomBritishDirector173205650001
    FLANAGAN, Jeffrey Paul
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    পরিচালক
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    United KingdomBritishDirector50878080003
    FOALE, Stephen John
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    পরিচালক
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant37403500001
    GORTON, Andrew
    Cark Hall Farm
    LA11 7NS Cark In Cartmell
    পরিচালক
    Cark Hall Farm
    LA11 7NS Cark In Cartmell
    BritishSolicitor45410310001
    GRAY, Susan Annette
    19 Swinburne Road
    Putney
    SW15 5ED London
    পরিচালক
    19 Swinburne Road
    Putney
    SW15 5ED London
    United KingdomBritishDirector55858850004
    HAMMOND, Mark William
    1a Overstone Road
    AL5 5PN Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    1a Overstone Road
    AL5 5PN Harpenden
    Hertfordshire
    BritishVenture Capitalist75015550001
    HARLAND, David Nicholas
    The Brooms
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    England
    পরিচালক
    The Brooms
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    England
    EnglandBritishAccountant173208950001
    HEADLEY, Linda Carol
    174 Pippin Street
    L40 7SP Burscough
    Lancashire
    পরিচালক
    174 Pippin Street
    L40 7SP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director87955630001
    HEADLEY, Linda Carol
    174 Pippin Street
    L40 7SP Burscough
    Lancashire
    পরিচালক
    174 Pippin Street
    L40 7SP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishCommunity Care Service87955630001
    HEADLEY, Michael
    174 Pippin Street
    Burscough
    L40 7SP Ormskirk
    Lancashire
    পরিচালক
    174 Pippin Street
    Burscough
    L40 7SP Ormskirk
    Lancashire
    United KingdomBritishCommunity Care Service30560120002
    JACKSON, David
    Institute Cottage
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Institute Cottage
    Church Road Great Milton
    OX44 7PD Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director280628560001
    LAWRENCE, Kenneth William
    4 The Headway
    KT17 1UJ Ewell
    Surrey
    পরিচালক
    4 The Headway
    KT17 1UJ Ewell
    Surrey
    United KingdomBritishVenture Capitalist40388380001
    MAHONY, Denis William
    Axholme 76 Thurstaston Road
    Heswall
    CH60 4SA Wirral
    Merseyside
    পরিচালক
    Axholme 76 Thurstaston Road
    Heswall
    CH60 4SA Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritishCompany Chairman13044150001
    MANNAN, Rohit
    Monarch Court, The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8
    United Kingdom
    পরিচালক
    Monarch Court, The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector181783660001
    ORME, Geoffrey Michael
    35 The Avenue
    ST15 8DG Stone
    Staffordshire
    পরিচালক
    35 The Avenue
    ST15 8DG Stone
    Staffordshire
    BritishChartered Accountant74927190001
    SCRAGG, Neil Grant
    70 Clarence Road
    AL1 4NG St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    70 Clarence Road
    AL1 4NG St. Albans
    Hertfordshire
    BritishInvestment Director76118110004
    SEBAG-MONTEFIORE, Charles Adam Laurie
    21 Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LT London
    পরিচালক
    21 Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LT London
    United KingdomBritishDirector Of Corporate Finance9439290001
    SMITH, John Richard Lloyd
    37 Yateley Road
    Edgbaston
    B15 3JP Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    37 Yateley Road
    Edgbaston
    B15 3JP Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director3664990001

    COMMUNITY CARELINE SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ অক্টো, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ জানু, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২১ অক্টো, ২০০৬বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৬ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any present or future debt. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bibby Factors Northwest LTD
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of keyman life policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assigns the policy and all sums assured by it and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১২ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of keyman life policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assigns the policy, all sum assured by it and all bonuses.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১২ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the holders from time to time of the notes issued pursuant to the loan note instrument constituting twin rate secured loan notes due 2006
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gresham Trust P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ১৪ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ জানু, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the holders of the notes issued pursuant to the loan note instrument constituting fixed rate secured loan notes due 2006
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gresham Trust PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ জানু, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০২ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of keyman life policy
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The policy number X71193312 with standard life assurance company for the sum of £200,000 on the life of mrs susan jane aylmer.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of keyman life policy
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The policy number X71193259 with standard life assurance company for the sum of £200,000 on the life of mr gregory aylmer.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ জানু, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge on debts and related rights
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুল, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to a factoring agreement and all the companys rights under a supply contract.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bibby Financial Services Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over book debts
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Any balance due from the company to the chargee under the loans as defined in a subscription and option agreement entered into on the 30TH may 1997
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All book debts and other debts now or in future owing to the company and arising under or pursuant to or in connection with franchise agreement entered into with kays food group PLC in respect of the following territories :-wetherby, blackpool (north), northampton (1), blackpool (south) see form 395 for further details. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kays Food Group PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুন, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0