BB & EA LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBB & EA LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02702539
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BB & EA LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (4525) /
    • (4550) /

    BB & EA LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    New Chartford House
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BB & EA LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SOVCO 452 LIMITED৩১ মার্চ, ১৯৯২৩১ মার্চ, ১৯৯২

    BB & EA LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে

    BB & EA LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    7 পৃষ্ঠা4.71

    ১৩ আগ, ২০১০ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    legacy

    1 পৃষ্ঠাLQ02

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০১ জুল, ২০১০ তারিখে

    LRESSP

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    লিকুইডেশন বাতিল করার আদালতের আদেশ

    1 পৃষ্ঠাOCRESCIND

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Renew Corporate Director Limited-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP02

    পরিচালক হিসাবে David Goodby এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ০৪ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    1 পৃষ্ঠাCOCOMP

    ০৪ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288b

    BB & EA LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Lovell House
    616 Chiswick High Road
    W4 5RX London
    কর্পোরেট সচিব
    Lovell House
    616 Chiswick High Road
    W4 5RX London
    41291250013
    CARLISLE, Edward
    Unit 4b Interchange
    25 Business Park Bostocks Lane
    NG10 5QG Sandiacre
    Nottingham
    পরিচালক
    Unit 4b Interchange
    25 Business Park Bostocks Lane
    NG10 5QG Sandiacre
    Nottingham
    BritishFinance Director63224850002
    LENNON, Martin Hugh
    38 Twentywell Road
    Bradway
    S17 4PW Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    38 Twentywell Road
    Bradway
    S17 4PW Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector95748100001
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Main Street
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    Main Street
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর04843611
    152232750001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    সচিব
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    BETTELL, Jonathan James
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    সচিব
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    BritishFinance Director42245740001
    BETTELL, Jonathan James
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    সচিব
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    BritishFinance Director42245740001
    BLACKMORE, Donald
    21 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    Bedfordshire
    সচিব
    21 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director2224110001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    সচিব
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British43547190001
    DAY, Simon Philip
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    সচিব
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    British71393050001
    EVANS, Clifford Stuart
    8 Myrtle Road
    MK42 0QT Bedford
    Bedfordshire
    সচিব
    8 Myrtle Road
    MK42 0QT Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Secretary40039730001
    SINCLAIR, Stuart George Hammond
    Kimble Lodge Holly Lane
    Silchester
    RG7 2NA Reading
    Berkshire
    সচিব
    Kimble Lodge Holly Lane
    Silchester
    RG7 2NA Reading
    Berkshire
    British4109700001
    SOVSHELFCO (SECRETARIAL) LIMITED
    PO BOX 8 Sovereign House
    South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট সচিব
    PO BOX 8 Sovereign House
    South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    35679850001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    পরিচালক
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    BritishFinance Director31113100001
    BETTELL, Jonathan James
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director42245740001
    BETTELL, Jonathan James
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    BritishFinance Director42245740001
    BLACKMORE, Donald
    21 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    21 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director2224110001
    BREALEY, Graham Michael
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director61631390001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    পরিচালক
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    BritishAccountant43547190001
    DAY, Simon Philip
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    পরিচালক
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishCompany Director71393050001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    পরিচালক
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    BritishExecutive66800550001
    GOODBY, David Anthony
    124 Thistle Grove
    AL7 4AQ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    পরিচালক
    124 Thistle Grove
    AL7 4AQ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishCompany Director66090530001
    HEWLETT, David
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    পরিচালক
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director87102720001
    ISAACSON, Timothy John
    11 The Graylings
    Putnoe
    MK41 9BH Bedford
    পরিচালক
    11 The Graylings
    Putnoe
    MK41 9BH Bedford
    BritishSales Director63148360001
    JENNINGS, David Frederick
    20 Wyboston Court
    Eaton Socon
    PE19 8PL St. Neots
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    20 Wyboston Court
    Eaton Socon
    PE19 8PL St. Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector74159440001
    LEWIS, Hector Thomas
    16 Almond Close
    Barby
    CV23 8TL Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    16 Almond Close
    Barby
    CV23 8TL Rugby
    Warwickshire
    BritishCompany Director2224140001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    পরিচালক
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    BritishChartered Accountant1571200002
    MILLER, David Harry
    46 Milton Avenue
    SM1 3QE Sutton
    Surrey
    পরিচালক
    46 Milton Avenue
    SM1 3QE Sutton
    Surrey
    BritishDirector15488900001
    NELMES CROCKER, Michael
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    BritishCompany Director1729130003
    PARKINSON, Ronald
    2 Hollies Close
    SG8 7DZ Royston
    Hertfordshire
    পরিচালক
    2 Hollies Close
    SG8 7DZ Royston
    Hertfordshire
    BritishCompany Director2224150001
    PELHAM, Michael Leslie
    Highfield Vicarage Road
    RG9 1HU Henley On Thames
    Oxon
    পরিচালক
    Highfield Vicarage Road
    RG9 1HU Henley On Thames
    Oxon
    BritishDirector3576830001
    ROBSON, Vincent Maurice
    18 Holmewood Crescent
    Holme
    PE7 3PY Peterborough
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    18 Holmewood Crescent
    Holme
    PE7 3PY Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishDirector58714670001
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    পরিচালক
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritishFinance Director50761250001
    SINCLAIR, Stuart George Hammond
    Kimble Lodge Holly Lane
    Silchester
    RG7 2NA Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Kimble Lodge Holly Lane
    Silchester
    RG7 2NA Reading
    Berkshire
    BritishDirector4109700001
    STEVENS, Anthony Henry Joseph
    111a Wootton Road
    PE30 4DJ Kings Lynn
    Norfolk
    পরিচালক
    111a Wootton Road
    PE30 4DJ Kings Lynn
    Norfolk
    EnglandEnglishDirector67780380001

    BB & EA LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ জানু, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জানু, ২০০০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১২ জানু, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ সেপ, ২০০১একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (405 (1))
    • ১৮ সেপ, ২০০১একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (405 (1))
    • 1১৭ আগ, ২০১০একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (LQ02)
      • মামলা নম্বর 1
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and bb & ea holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ আগ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৯ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a 123/125 nathan way woolwich london t/no SGL33432 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a land on the north side of austin fields kings lynn norfolk t/n nk 125997 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 63 and 65 london road sandy bedfordshire t/n bd 171704 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold cavendish garage richardshaw lane stanningley pudsey west yorkshire t/n wyk 512414 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land on the south east side of bennerley road bulwell nottingham nottinghamshire t/n nt 133280 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H bath road lower parkway reading berkshire t/n bk 22551 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H access house leabrook road wednesbury west midlands t/n wm 558011 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold plot 9 austin fields kings lynn norfolk t/n nk 120087 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 41 ellgreage street burslem stoke on trent staffordshire t/n sf 313192 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    BB & EA LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১১ জানু, ২০০০যন্ত্রের তারিখ
    প্রশাসনিক রিসিভার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Michael Vincent Mcloughlin
    Kpmg
    24 Blytheswood Square
    G2 3QS Glasgow
    অভ্যাসকারী
    Kpmg
    24 Blytheswood Square
    G2 3QS Glasgow
    Gerard Anthony Friar
    24 Blythswood Square
    Glasgow
    G2 4QS
    অভ্যাসকারী
    24 Blythswood Square
    Glasgow
    G2 4QS
    2
    তারিখপ্রকার
    ১৯ মার্চ, ২০১০ওয়াইন্ডিং আপ শেষ
    ১৩ অক্টো, ২০০৮আবেদন তারিখ
    ১৩ জানু, ২০০৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    বাধ্যতামূলক তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    অভ্যাসকারী
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    4
    তারিখপ্রকার
    ০১ জুল, ২০১০ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৮ জানু, ২০১২ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Christopher Wood
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0