VANGUARD PLC

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামVANGUARD PLC
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02724392
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    VANGUARD PLC এর উদ্দেশ্য কী?

    • (6420) /

    VANGUARD PLC কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O B And C Associates Trafalgar
    House Grenville Place
    NW7 3SA Mill Hill
    London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    VANGUARD PLC এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    VANGUARD COMMUNICATIONS PLC১০ মার্চ, ১৯৯৩১০ মার্চ, ১৯৯৩
    VANGUARD PLC১০ মার্চ, ১৯৯৩১০ মার্চ, ১৯৯৩
    VINYLMILL LIMITED১৯ জুন, ১৯৯২১৯ জুন, ১৯৯২

    VANGUARD PLC এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মে, ২০০৩

    VANGUARD PLC এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ১৯ জানু, ২০১২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.72

    ২৫ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৫ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৫ অক্টো, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৫ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৫ অক্টো, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেটর হিসাবে কাজ বন্ধ করার নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা4.40

    দেউলিয়া আদালতের আদেশ

    Court order INSOLVENCY:removal/re-placement of liquidator
    18 পৃষ্ঠাLIQ MISC OC

    ২৫ এপ্রি, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৫ অক্টো, ২০০৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৫ অক্টো, ২০০৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    12 পৃষ্ঠা2.34B

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    12 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    20 পৃষ্ঠা2.24B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    27 পৃষ্ঠা2.17B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    VANGUARD PLC এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MCFARLANE, Michael John
    56 Broadfields
    Norton
    WA7 6UE Runcorn
    Cheshire
    সচিব
    56 Broadfields
    Norton
    WA7 6UE Runcorn
    Cheshire
    BritishAccountant108894980001
    IKIN, Steven Robert
    86 Douglas Drive
    CH46 6BX Moreton
    পরিচালক
    86 Douglas Drive
    CH46 6BX Moreton
    EnglandBritishAccountant100890700001
    MCFARLANE, Michael John
    56 Broadfields
    Norton
    WA7 6UE Runcorn
    Cheshire
    পরিচালক
    56 Broadfields
    Norton
    WA7 6UE Runcorn
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant108894980001
    CHENINI, Abderrazak
    290b Neasden Lane
    Neasdon
    NW10 0EP London
    সচিব
    290b Neasden Lane
    Neasdon
    NW10 0EP London
    British96679010001
    FULLER, Andrew Jonathan
    Woodland Park
    Whalley
    BB7 9UG Lancashire
    28
    সচিব
    Woodland Park
    Whalley
    BB7 9UG Lancashire
    28
    BritishFinancial Director132077340001
    GHUMAN, Anis
    16 Whippendell Road
    WD18 7LU Watford
    Hertfordshire
    সচিব
    16 Whippendell Road
    WD18 7LU Watford
    Hertfordshire
    BritishDirector78696610001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    মনোনীত সচিব
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    HUGHES, Howard William
    Acaster 181 Banks Road
    West Kirby
    CH48 3HU Wirral
    Merseyside
    সচিব
    Acaster 181 Banks Road
    West Kirby
    CH48 3HU Wirral
    Merseyside
    BritishDirector71000190002
    JENKINS, David Peter
    2 Holly Bush Close
    Netherseal
    DE12 8DD Swadlincote
    Derbyshire
    সচিব
    2 Holly Bush Close
    Netherseal
    DE12 8DD Swadlincote
    Derbyshire
    BritishSolicitor100695380001
    MADDOCKS, Paul
    The Briars
    3 Grey Close
    CH5 3TX Hawarden
    Flintshire
    সচিব
    The Briars
    3 Grey Close
    CH5 3TX Hawarden
    Flintshire
    BritishFinancial Director71330350001
    TAHIR, Mohammad Idrees
    128 Westmount Road
    SE9 1UT London
    সচিব
    128 Westmount Road
    SE9 1UT London
    UsaConsultant107361410001
    WARD, Warren
    Mindale House
    Ffordd Hendre
    LL19 8PG Prestatyn
    Clwyd
    সচিব
    Mindale House
    Ffordd Hendre
    LL19 8PG Prestatyn
    Clwyd
    British68652570001
    WHITLEY, Richard John
    57 Bryn Celyn
    LL29 6DH Colwyn Bay
    Clwyd
    সচিব
    57 Bryn Celyn
    LL29 6DH Colwyn Bay
    Clwyd
    BritishTelecommunications Engineer30225840001
    WILEY, Nicholas Richard
    18 Hillersdon Avenue
    Barnes
    SW13 0EF London
    সচিব
    18 Hillersdon Avenue
    Barnes
    SW13 0EF London
    BritishDirector124980050001
    BEDESHA, Jack
    9 Clarendon Place
    CV32 5QP Leamington Spa
    Warwickshire
    পরিচালক
    9 Clarendon Place
    CV32 5QP Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector93393000001
    CORRY, Kelvin Sidney
    53 Kelington Denbigh Circle
    Kinmel Bay
    LL18 5HW Rhyl
    Conwy
    North Wales
    পরিচালক
    53 Kelington Denbigh Circle
    Kinmel Bay
    LL18 5HW Rhyl
    Conwy
    North Wales
    BritishCompany Director44882150006
    CROSSMAN, Paul Anthony
    Quest House 21 Downham Road
    Ramsden Heath
    CM11 1PU Billericay
    Essex
    পরিচালক
    Quest House 21 Downham Road
    Ramsden Heath
    CM11 1PU Billericay
    Essex
    EnglandBritishDirector81234350001
    FIDANZA, Paolo
    48 Northcourt Avenue
    RG2 7HQ Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    48 Northcourt Avenue
    RG2 7HQ Reading
    Berkshire
    ItalianDirector76984050002
    FULLER, Andrew Jonathan
    Woodland Park
    Whalley
    BB7 9UG Lancashire
    28
    পরিচালক
    Woodland Park
    Whalley
    BB7 9UG Lancashire
    28
    BritishFinancial Director132077340001
    GHUMAN, Anis
    16 Whippendell Road
    WD18 7LU Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    16 Whippendell Road
    WD18 7LU Watford
    Hertfordshire
    BritishDirector78696610001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    মনোনীত পরিচালক
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    HERITAGE, Ian
    Barn Cottage
    Sheepwash Lane
    DY11 5SF Wolverley
    Worcestershire
    পরিচালক
    Barn Cottage
    Sheepwash Lane
    DY11 5SF Wolverley
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector97028170001
    HUGHES, Howard William
    Acaster 181 Banks Road
    West Kirby
    CH48 3HU Wirral
    Merseyside
    পরিচালক
    Acaster 181 Banks Road
    West Kirby
    CH48 3HU Wirral
    Merseyside
    BritishFinancial Director71000190002
    MADDOCKS, Paul
    The Briars
    3 Grey Close
    CH5 3TX Hawarden
    Flintshire
    পরিচালক
    The Briars
    3 Grey Close
    CH5 3TX Hawarden
    Flintshire
    United KingdomBritishManaging Director71330350001
    SUTHERLAND, John Alan
    14 Ffordd Nant
    Kinmel Bay
    LL18 5JN Rhyl
    Clwyd
    পরিচালক
    14 Ffordd Nant
    Kinmel Bay
    LL18 5JN Rhyl
    Clwyd
    BritishChairman68450380001
    SUTHERLAND, Margaret Elize
    14 Ffordd Nant
    Clwyd Park Kinmel Bay
    LL18 4JN Rhyl
    Clwyd
    পরিচালক
    14 Ffordd Nant
    Clwyd Park Kinmel Bay
    LL18 4JN Rhyl
    Clwyd
    BritishDirector43360660001
    TAHIR, Mohammad Idrees
    128 Westmount Road
    SE9 1UT London
    পরিচালক
    128 Westmount Road
    SE9 1UT London
    UsaConsultant107361410001
    WHITLEY, Richard John
    57 Bryn Celyn
    LL29 6DH Colwyn Bay
    Clwyd
    পরিচালক
    57 Bryn Celyn
    LL29 6DH Colwyn Bay
    Clwyd
    BritishTechnical Director30225840001
    WILEY, Nicholas Richard
    18 Hillersdon Avenue
    Barnes
    SW13 0EF London
    পরিচালক
    18 Hillersdon Avenue
    Barnes
    SW13 0EF London
    United KingdomBritishDirector124980050001
    WILSON, Neville Leslie
    38 Shelburn Drive
    CW1 5QG Haslington
    Cheshire
    পরিচালক
    38 Shelburn Drive
    CW1 5QG Haslington
    Cheshire
    South AfricanSales Director58229000001
    WRIGHT, Ian
    12 Langford Place
    G53 7HZ Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    12 Langford Place
    G53 7HZ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector65757480001

    VANGUARD PLC এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All f/h and l/h property all fixtures and fittings plant and machinery vehicles and computer equipment all furniture furnishings equipment tools and other chattels all rents receivable goodwill and uncalled capital intellectua property rights choses in action licenced and claims all income and rights book debts and other debts all funds standing to the credit of the company with any bank or other institution.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gemcorp Aureole
    ব্যবসায়
    • ০৭ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All f/h and l/h property and fixtures and fittings all plant and machinery and vehicles and computer equipment and all furniture furnishings equipment tools and chattels all goodwill and uncalled capital and stocks and shares and securities all intellectual property and insurance and policies all book and other debts and bank accounts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gemcorp Aureole
    ব্যবসায়
    • ২৩ এপ্রি, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Vanguard technology park fford derwen rhyl denbighshire t/no WA869482. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Executive Aviation Fuel Services Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ মার্চ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £50,000 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings at 2 market street rhyl denbighshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • David Edward Brookes Parry
    ব্যবসায়
    • ০৭ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Martins cash and carry ffordd derwen road rhuddlan rhyl clwyd.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জানু, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জানু, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ জানু, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    VANGUARD PLC এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৫ মে, ২০০৬প্রশাসন শুরু
    ২৬ এপ্রি, ২০০৭প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Jeffrey Mark Brenner
    B & C Associates Limited Trafalgar House
    Grenville Place Mill Hill
    NW7 3SA London
    অভ্যাসকারী
    B & C Associates Limited Trafalgar House
    Grenville Place Mill Hill
    NW7 3SA London
    Filippa Bjorg Connor
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    South Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    South Yorkshire
    2
    তারিখপ্রকার
    ২৬ এপ্রি, ২০০৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৯ জুন, ২০১২ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Jeffrey Mark Brenner
    B & C Associates Limited Trafalgar House
    Grenville Place Mill Hill
    NW7 3SA London
    অভ্যাসকারী
    B & C Associates Limited Trafalgar House
    Grenville Place Mill Hill
    NW7 3SA London
    Filippa Bjorg Connor
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    South Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    South Yorkshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0