UKRD GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামUKRD GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02725453
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    UKRD GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    UKRD GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    UKRD GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    UK RADIO HOLDINGS LIMITED০৪ নভে, ১৯৯২০৪ নভে, ১৯৯২
    PRINTRECORD LIMITED২৪ জুন, ১৯৯২২৪ জুন, ১৯৯২

    UKRD GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২০

    UKRD GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    ২৪ জুন, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    46 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    ২৪ জুন, ২০২১ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ সেপ, ২০২০ থেকে ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    38 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ০২ অক্টো, ২০২০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancel share prem a/c 15/09/2020
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ১৪ সেপ, ২০২০ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 14,198,749.95
    3 পৃষ্ঠাSH01

    ২০ আগ, ২০২০ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণের দ্বিতীয় দাখিল

    • মূলধন: GBP 12,485,749.95
    4 পৃষ্ঠাRP04SH01

    ২০ আগ, ২০২০ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 12,485,750
    4 পৃষ্ঠাSH01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৩ সেপ, ২০২০Clarification A second filed SH01 was registered on 23/09/2020

    ২০ আগ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Laws Wenger এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ আগ, ২০২০ তারিখে সচিব হিসাবে Bauer Group Secretariat Ltd-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    ২০ আগ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Richard Preece এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ আগ, ২০২০ তারিখে সচিব হিসাবে Andrew Preece এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    11 পৃষ্ঠাMA

    UKRD GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BAUER GROUP SECRETARIAT LTD
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর944753
    270106790001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    পরিচালক
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    United KingdomBritish109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    পরিচালক
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    পরিচালক
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    EnglandBritish119137220004
    CLAYTON, Yvonne Lynn
    South Bank
    31a Woodland Avenue
    TR10 8PG Penryn
    Cornwall
    সচিব
    South Bank
    31a Woodland Avenue
    TR10 8PG Penryn
    Cornwall
    British40640850001
    HUMM, Roger James
    Dinghurst Road
    Churchill
    BS25 5PJ Winscombe
    Westfield Orchard
    Avon
    সচিব
    Dinghurst Road
    Churchill
    BS25 5PJ Winscombe
    Westfield Orchard
    Avon
    British29914990003
    HYDE, Gerard Joseph
    74 South Audley Street
    W1Y 5FF London
    সচিব
    74 South Audley Street
    W1Y 5FF London
    British78298560002
    PREECE, Andrew
    Carn Brea Studios
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Ukrd Group Limited
    Cornwall
    United Kingdom
    সচিব
    Carn Brea Studios
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Ukrd Group Limited
    Cornwall
    United Kingdom
    157611600001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AARONSON, Glenn Hunter
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    পরিচালক
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    NetherlandsAmerican129927520014
    ANDERSON, Michael
    40 Evans Street
    Bronte
    New South Wales
    2024
    Australia
    পরিচালক
    40 Evans Street
    Bronte
    New South Wales
    2024
    Australia
    Australian96506420001
    BENSON, Peter Michael
    Juli Garreta 22
    Girona
    Catalonia 17002
    Spain
    পরিচালক
    Juli Garreta 22
    Girona
    Catalonia 17002
    Spain
    Australian69167380004
    BICKMORE, Brian Lindsay
    26a Lansell Road
    Toorak
    Melbourne 3142
    Australia
    পরিচালক
    26a Lansell Road
    Toorak
    Melbourne 3142
    Australia
    AustraliaAustralian153909330001
    BODDY, David James
    7 The Sanctuary Parliament Square
    Westminster
    SW1P 3JS London
    পরিচালক
    7 The Sanctuary Parliament Square
    Westminster
    SW1P 3JS London
    New Zealand30018020004
    BRUCE, David Kevin
    Rose Cottage
    Wanborough
    GU3 2JR Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Rose Cottage
    Wanborough
    GU3 2JR Guildford
    Surrey
    British37948150003
    DARCH, Jonathan Robert
    The Barn, Court Farm
    Station Road, Blagdon
    BS40 7TD Bristol
    Avon
    পরিচালক
    The Barn, Court Farm
    Station Road, Blagdon
    BS40 7TD Bristol
    Avon
    EnglandBritish40673150002
    EVERETT, Anthony David
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    পরিচালক
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    EnglandBritish172501910001
    FOO, Peter Edwin
    460 Kangaroo Ground
    Warrandyte Road
    Kangaroo Ground
    Victoria 3097
    Australia
    পরিচালক
    460 Kangaroo Ground
    Warrandyte Road
    Kangaroo Ground
    Victoria 3097
    Australia
    Australian50668310001
    HANDLEY, Valerie Jayne
    Spring Cottage
    Stoney Bottom Grayshott
    GU26 6HN Hindhead
    Surrey
    পরিচালক
    Spring Cottage
    Stoney Bottom Grayshott
    GU26 6HN Hindhead
    Surrey
    EnglandBritish44328220001
    HASKELL, Mark John
    Manor Cottage
    Lower Netherton
    TQ12 4RL Newton Abbot
    Devon
    পরিচালক
    Manor Cottage
    Lower Netherton
    TQ12 4RL Newton Abbot
    Devon
    British24095130004
    HASKELL, Mark John
    1 Copperwood Close
    Ashburton
    TQ13 7JQ Newton Abbot
    Devon
    পরিচালক
    1 Copperwood Close
    Ashburton
    TQ13 7JQ Newton Abbot
    Devon
    British24095130003
    HEPBURN, John Keith
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    পরিচালক
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    EnglandCanadian16344860001
    HUMM, Roger James
    Dinghurst Road
    Churchill
    BS25 5PJ Winscombe
    Westfield Orchard
    Avon
    পরিচালক
    Dinghurst Road
    Churchill
    BS25 5PJ Winscombe
    Westfield Orchard
    Avon
    EnglandBritish29914990003
    HYDE, Gerard Joseph
    74 South Audley Street
    W1Y 5FF London
    পরিচালক
    74 South Audley Street
    W1Y 5FF London
    British78298560002
    IBBOTSON, Peter Stamford
    Newnham Farm House
    OX10 8BW Wallingford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Newnham Farm House
    OX10 8BW Wallingford
    Oxfordshire
    British8069000001
    KITNEY, Stephen James
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    British90188890001
    LAWLEY, Richard Henry John
    3 Pine Bank
    GU26 6SR Hindhead
    Surrey
    পরিচালক
    3 Pine Bank
    GU26 6SR Hindhead
    Surrey
    EnglandBritish83623820001
    MCCGWIRE, Patrick Conor
    76a Deodar Road
    SW15 2NJ London
    পরিচালক
    76a Deodar Road
    SW15 2NJ London
    British59628620001
    ORME, Simon Patrick
    1 Aubrey Road
    W8 7JJ London
    পরিচালক
    1 Aubrey Road
    W8 7JJ London
    American39459500001
    PINCHAM, Roger James
    7 The Postern
    Wood Street, Barbican
    EC2Y 8BJ London
    পরিচালক
    7 The Postern
    Wood Street, Barbican
    EC2Y 8BJ London
    United KingdomBritish16343790001
    POWELL, Michael Leslie
    Nightingale Cottage
    Great Holt Old Lane Dockenfield
    GU10 4HQ Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Nightingale Cottage
    Great Holt Old Lane Dockenfield
    GU10 4HQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish11273310001
    PREECE, Andrew Richard
    Carn Brea Studios
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Ukrd Group Limited
    Cornwall
    United Kingdom
    পরিচালক
    Carn Brea Studios
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Ukrd Group Limited
    Cornwall
    United Kingdom
    EnglandBritish158905700001
    REDFARN, Stephen Charles
    Moray House
    PL20 6DF Yelverton
    Devon
    পরিচালক
    Moray House
    PL20 6DF Yelverton
    Devon
    United KingdomBritish75074990002
    ROGERS, William James Gerald
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    পরিচালক
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    EnglandBritish37957110009
    SMALLWOOD, Trevor
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    পরিচালক
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritish1535550001

    UKRD GROUP LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Bauer Radio Limited
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    ৩১ মার্চ, ২০১৯
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    UKRD GROUP LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সর্বশেষ বিবৃতিগুলি কী কী?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
    জানানো হয়েছেবন্ধ হয়েছেবিবৃতি
    ২৪ জুন, ২০১৭৩১ মার্চ, ২০১৯কোম্পানি জানে বা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত কোন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা নিবন্ধনযোগ্য প্রাসঙ্গিক আইনি সত্তা নেই

    UKRD GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুন, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুন, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৭ মে, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deposit agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge all such rights to the repayment of the deposit as the depositor may have under the terms upon which the deposit was made. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ সেপ, ২০০৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১২ সেপ, ২০০৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৫ জানু, ২০১৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Charge over shares and memorandum of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and pirate to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of the shares warrants coupons talons and/or intruments representing such shares and all cash securities dividends rights and other property all other property hereafter delivered to the security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Baring Trust Co Limited Acting as Security Trustee on Behalf of the Loan Stock Holders
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £600,000 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of its right title and interest in and to the shares (being all of the issued a ordinary shares and b ordinary shares of pirate fm limited) and all proceeds therefrom.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Marazion Holdings Limited, John Hepburn, Trevor Smallwood and Simon Orme
    ব্যবসায়
    • ২৯ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All deposits credited to account designation 10054572 with the bank and any deposit or account of any other currency. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage of shares
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company,previously known as UK radio holdings limited,to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    468,500 shares in the capital of cornwall independent radio limited with all dividends declared and all shares stocks securities rights or properties offered to shareholders. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I Group PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জানু, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ সেপ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cornwall Independent Radio Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ সেপ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 ref. M237C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I Group PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0