THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTHE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02748038
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Marstons House
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে০২ অক্টো, ২০২১

    THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    2 পৃষ্ঠাDS01

    ০৭ সেপ, ২০২২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancel share premium account 05/09/2022
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ০৫ সেপ, ২০২২ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 874,158
    3 পৃষ্ঠাSH01

    ২৭ জুন, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ০২ অক্টো, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ অক্টো, ২০২১ তারিখে সচিব হিসাবে Anne Marie Brennan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৫ অক্টো, ২০২১ তারিখে সচিব হিসাবে Mrs Michelle Louise Woodall-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০৫ অক্টো, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Edward Hancock-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৫ অক্টো, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Robert Anthony Leach-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৫ অক্টো, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Hayleigh Lupino-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০২ অক্টো, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ralph Graham Findlay এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৭ জুন, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ০৩ অক্টো, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ অক্টো, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Richard James Westwood এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৭ জুন, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৮ সেপ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ জুন, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৯ সেপ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ জুন, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WOODALL, Michelle Louise
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    সচিব
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    288186710001
    ANDREA, Andrew Andonis
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    পরিচালক
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director137383120001
    HANCOCK, Edward John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor288133210001
    LEACH, Robert Anthony
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Treasury194085550001
    LUPINO, Hayleigh
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director207826950002
    ADAMS, Paul Francis
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    সচিব
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    British125526410001
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    সচিব
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BRENNAN, Anne Marie
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    সচিব
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Secretary109935620001
    BRYAN, Nicholas George
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    সচিব
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    BritishCompany Director65460520003
    SHAH, Vimal
    9 Southfield Road
    Chiswick
    W4 1AG London
    সচিব
    9 Southfield Road
    Chiswick
    W4 1AG London
    British4692040001
    WEST, Alan
    29 Oak Manor Drive
    GL52 6SZ Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    29 Oak Manor Drive
    GL52 6SZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishFinancial Controller111318570001
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    কর্পোরেট সচিব
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    106817380001
    ADAMS, Paul Francis
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    পরিচালক
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    EnglandBritishChartered Accountant125526410001
    ANDREW, Derek
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    পরিচালক
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director39071260003
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BRYAN, Nicholas George
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    পরিচালক
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director65460520003
    CHOWDHARY, Balvinder Kaur
    112 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HR Hampton
    Middlesex
    পরিচালক
    112 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HR Hampton
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Registration Agent4672940001
    COYLE, James Arthur
    Glen Ruther College Road
    Denstone
    ST14 5HR Uttoxeter
    Staffordshire
    পরিচালক
    Glen Ruther College Road
    Denstone
    ST14 5HR Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishSales Director63364040001
    DALZELL, Peter
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director163616170001
    DARBY, Alistair William
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    পরিচালক
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director87846880002
    DAVIES, Martin William Oliver
    Dancing Waters
    The Friary
    SL4 2NS Old Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    Dancing Waters
    The Friary
    SL4 2NS Old Windsor
    Berkshire
    BritishManaging Director40444030001
    DENNING, Roland John
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    পরিচালক
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director95991510001
    FINDLAY, Ralph Graham
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    পরিচালক
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director129897400001
    GRACE, David Allen
    Lark Rise Home Farm Court
    East End Adderbury
    OX17 3NW Banbury
    Oxon
    পরিচালক
    Lark Rise Home Farm Court
    East End Adderbury
    OX17 3NW Banbury
    Oxon
    BritishCompany Director67926560001
    HAWTHORN, Stuart John
    3 Rutherford Close
    OX14 2AT Abingdon
    Oxfordshire
    পরিচালক
    3 Rutherford Close
    OX14 2AT Abingdon
    Oxfordshire
    BritishDirector82240190001
    INGLETT, Paul
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    পরিচালক
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director81617110002
    LUSCOMBE, Richard William
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    পরিচালক
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    BritishCompany Director70464690001
    MOSS, Arthur Christopher
    80 Bridge Street
    OX2 0BD Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    80 Bridge Street
    OX2 0BD Oxford
    Oxfordshire
    BritishBrewer30700880001
    OLIVER, Stephen John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    পরিচালক
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director66123690003
    ROGERS, Ian
    17 Burcott Park
    Burcott
    OX14 3DH Abingdon
    Oxfordshire
    পরিচালক
    17 Burcott Park
    Burcott
    OX14 3DH Abingdon
    Oxfordshire
    BritishManaging Director30700870003
    THOMPSON, Rupert Geoffrey Ryland
    The Hermitage
    RG17 0HA Hungerford
    Berks
    পরিচালক
    The Hermitage
    RG17 0HA Hungerford
    Berks
    EnglandBritishCompany Director30939200001
    WESTWOOD, Richard James
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director314691870001

    THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর03981399
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুন, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ নভে, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ অক্টো, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জানু, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Book debts debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future save for those book debts and other debts sold by the company and purchased by the chargee under an invoice discounting agreement and not purchased pursuant to the provisions thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • New Court Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold property known as units 10 and 11 eagle industrial estate the crofts witney oxfordshire title number ON172245 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold property known as unit 12 eagle industrial estate witney oxfordshire title number ON169190 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Collateral debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from hobgoblinns limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I Group PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Counterpart rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ আগ, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of a lease dated 11TH august 1994 and this deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £1066 or one quarter of the annual rent from time to time payable under the said lease dated 11TH august 1994 (whichever shall be the greater) together with a sum equivalent to the rate of V.A.T. currently charged on rent.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hambridge Investments (Newbury) Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed incorporating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of the lease dated 12TH may 1994.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £5,529 and all other monies deposited in the deposit account at lloyds bank PLC in the name of the chargee.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hambridge Investments (Newbury) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুল, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H-unit 9B two rivers industrial estate station lane witney oxfordshire. T/n-ON111965 and ON139732 and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0