FLEXIT IK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামFLEXIT IK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02752648
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    FLEXIT IK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /

    FLEXIT IK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    FLEXIT IK LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TRADERISE PUBLIC LIMITED COMPANY০২ অক্টো, ১৯৯২০২ অক্টো, ১৯৯২

    FLEXIT IK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৮

    FLEXIT IK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.71

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৭ ডিসে, ২০০৯ তারিখে

    LRESSP

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    FLEXIT IK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HAND, Kim Andrea
    Sutton Field
    Whitegate
    CW8 2BD Northwich
    Cherry Trees,
    Cheshire
    সচিব
    Sutton Field
    Whitegate
    CW8 2BD Northwich
    Cherry Trees,
    Cheshire
    British141032930001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    পরিচালক
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    EnglandBritish141025870003
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    32732300002
    FELLOWES, Colin
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    সচিব
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    British800670001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    সচিব
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    British141025870003
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    সচিব
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    SHELDON, Jeremy Nigel
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    সচিব
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    British80327250001
    RICHARD ELLIS FINANCIAL LIMITED
    C/O Richard Ellis
    55 Old Broad Street
    EC2M 1LP London
    কর্পোরেট সচিব
    C/O Richard Ellis
    55 Old Broad Street
    EC2M 1LP London
    32874470003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    British28998990001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    British28998990001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    British28998990001
    DEVINE, Stephen Colm
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Irish6552570001
    DEVINE, Stephen Colm
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Irish6552570001
    ELLINGHAM, Hugh Vere Alexander
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish36926690001
    FITZGERALD, Michael Thomas
    Whin Cottage St Michaels Drive
    TN14 5SA Otford
    Kent
    পরিচালক
    Whin Cottage St Michaels Drive
    TN14 5SA Otford
    Kent
    British62403370002
    FRASER, Richard Lindsay
    Meadowgarth Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Meadowgarth Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British13770640001
    HOLLAND, Peter James
    Woodside House
    Wynnstay Lane, Marford
    LL12 8LH Wrexham
    পরিচালক
    Woodside House
    Wynnstay Lane, Marford
    LL12 8LH Wrexham
    WalesBritish75624260001
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    PEARCE, Daniel Norton Idris, Sir
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    পরিচালক
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    British45656280001
    RATCLIFFE, Michael Arthur
    9 Leigh Court Close
    KT11 2HT Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    9 Leigh Court Close
    KT11 2HT Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish11387510001
    ROUGHTON, Dominic David
    10 Danbury Street
    Islington
    N1 8JU London
    পরিচালক
    10 Danbury Street
    Islington
    N1 8JU London
    British30738920001
    SHELDON, Jeremy Nigel
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    পরিচালক
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    British80327250001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    FLEXIT IK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 18 crusader court earlswood.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 60 phase 2A (1) foxholes hertford hertfordshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed 14TH january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 157 claremont, essex hall.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ফেব, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plots 17 8 and 10 crusaders court st. Johns terrace road earlswood, plots 18 and 23 manor drive wembley. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ফেব, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising from or as a result of a material breach by the company of one or more of the covenants and undertakings given by the company pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed for the sale and purchase of the business of the company dated 14 january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plots 3 and 162 carreg yr afon glan yr afon graig newydd godre'r graig pontardawe west glamorgan.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ফেব, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising from or as a result of a material breach by the company of one or more of the covenants and undertakings given by the company pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed for the sale and purchase of the business of the company dated 14 january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plots 80, 90 and 262 herons reach blackpool.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ডিসে, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 179 lodge lane, hyde.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জুল, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14/1/93
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    27, 24, 46, 47 spring gardens ince.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুল, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 165 godre'r graig swansea.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুল, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 146 godre'r graig swansea.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    413 cyclops wharf, west ferry road, london.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 152 godre'r graig, swansea.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    3.19, 5.09, 5.15 & 6.15 king and queen wharf, rotherhithe, 60 regents gate, foxholes, stansted road, 80 shires, greenbank, borough road.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    224 cyclops wharf west ferry road london.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ জুন, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুন, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in the legal charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 329 on the companys estate at cyclops wharf, west ferry road, london.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জুন, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plots 60,68 willow green,robertsbridge and plot 117 lytton gate,woolmer green.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 88 on the company's estate at phase 3 beckside west green, pocklington t/no: h 171354 (see ch microfiche for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ ফেব, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জানু, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ফেব, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call options deed of even date and under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See 395 for full details and property details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ ফেব, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    FLEXIT IK LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৭ ডিসে, ২০০৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১০ এপ্রি, ২০১১ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Christopher John Brown
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0