LEGACY COMPANY THREE LTD.

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLEGACY COMPANY THREE LTD.
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02760037
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LEGACY COMPANY THREE LTD. এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    LEGACY COMPANY THREE LTD. কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    Cheshire
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LEGACY COMPANY THREE LTD. এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DEDICATED MICROS LIMITED২৯ মার্চ, ১৯৯৩২৯ মার্চ, ১৯৯৩
    NORTH CENTRAL CENTRAL SERVICES LIMITED২৯ অক্টো, ১৯৯২২৯ অক্টো, ১৯৯২

    LEGACY COMPANY THREE LTD. এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৫

    LEGACY COMPANY THREE LTD. এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    LEGACY COMPANY THREE LTD. এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ মে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Michael James Newton-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Pauline Anne Norstrom এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৭ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৭ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Helen Pamela Doroszkiewicz এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ১২ মার্চ, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Unit 1200 Daresbury Park Daresbury Warrington WA4 4HS থেকে No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JBপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ জুন, ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২১ ডিসে, ২০১৫

    ২১ ডিসে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ নভে, ২০১৪

    ২৬ নভে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,000
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed dedicated micros LIMITED\certificate issued on 11/03/14
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১১ মার্চ, ২০১৪

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১১ মার্চ, ২০১৪

    RES15
    change-of-name১১ মার্চ, ২০১৪

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩০ অক্টো, ২০১৩

    ৩০ অক্টো, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,000
    SH01

    ২৪ অক্টো, ২০১৩ তারিখে Mr Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    সচিব হিসাবে Mrs Helen Pamela Doroszkiewicz-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    LEGACY COMPANY THREE LTD. এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    NEWTON, Michael James
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    পরিচালক
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector24712770003
    BANNISTER, Stephen David
    Cock Lane Farm
    Warrington Road, Great Budworth
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    সচিব
    Cock Lane Farm
    Warrington Road, Great Budworth
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    British67739860001
    BENTLEY-BUCHANAN, Sarah
    Strines Road
    Strines
    SK6 7GA Stockport
    180
    Cheshire
    United Kingdom
    সচিব
    Strines Road
    Strines
    SK6 7GA Stockport
    180
    Cheshire
    United Kingdom
    British135492410001
    DOROSZKIEWICZ, Helen Pamela
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    সচিব
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    164871050001
    JOHNSON, Karen Louise
    18 Colwyn Road
    Bramhall
    SK7 2JQ Stockport
    Cheshire
    সচিব
    18 Colwyn Road
    Bramhall
    SK7 2JQ Stockport
    Cheshire
    British60983560001
    SPROTT, David
    Karinya 1 High Pell Gate Barns
    Cartmel Road
    LA11 7QX Grange Over Sands
    Cumbria
    সচিব
    Karinya 1 High Pell Gate Barns
    Cartmel Road
    LA11 7QX Grange Over Sands
    Cumbria
    BritishCertified Accountant106628420001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BANNISTER, Stephen David
    Cock Lane Farm
    Warrington Road, Great Budworth
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    Cock Lane Farm
    Warrington Road, Great Budworth
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    BritishDirector67739860001
    BARLOW, James
    15 Aspenwood Close
    Marple
    SK6 6NU Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    15 Aspenwood Close
    Marple
    SK6 6NU Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritishManaging Director21095060001
    CLAYTON JONES, Andrea Jayne
    1 Venables Way
    High Lea
    WA16 6LY Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    1 Venables Way
    High Lea
    WA16 6LY Knutsford
    Cheshire
    BritishCompany Director15214320001
    DRENT, Ivo
    Korbeeklosestraat 16
    Bierbeek 3360
    FOREIGN Belgium
    পরিচালক
    Korbeeklosestraat 16
    Bierbeek 3360
    FOREIGN Belgium
    BelgianEuropean Sales Director58744920001
    DUSARA, Paresh Devchand
    Park Cottage
    Wrenshot Lane, High Legh
    WA16 6PG Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    Park Cottage
    Wrenshot Lane, High Legh
    WA16 6PG Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishPurchasing Director64177820001
    ELLIOTT, John Martyn
    8 Spindlepoint Drive
    Worsley
    M28 7GL Manchester
    পরিচালক
    8 Spindlepoint Drive
    Worsley
    M28 7GL Manchester
    BritishCompany Director56423870001
    FAWCETT, Michael Alan
    94 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    পরিচালক
    94 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    BritishAccountant38913590002
    FINN, Andrew Patrick
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector169499300001
    HUMPHREY, John Eugene
    23 Whitland Avenue
    BL1 5FB Bolton
    Greater Manchester
    পরিচালক
    23 Whitland Avenue
    BL1 5FB Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritishManaging Director119278130001
    KULLESEID, Peter James
    9 Rooklands Scotter
    DN21 3TT Gainsborough
    Lincolnshire
    পরিচালক
    9 Rooklands Scotter
    DN21 3TT Gainsborough
    Lincolnshire
    BritishDirector56139320001
    NEWTON, Michael James
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6JB Nortwich
    Cheshire
    পরিচালক
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6JB Nortwich
    Cheshire
    EnglandBritishDirector24712770003
    NORSTROM, Pauline Anne
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    পরিচালক
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector148506110001
    O'DOWD, Christopher John
    Rathbane
    Princes Gate
    HX3 0EH Halifax
    Yorkshire
    পরিচালক
    Rathbane
    Princes Gate
    HX3 0EH Halifax
    Yorkshire
    EnglandIrishDirector92850910001
    OLIVER, Graeme William
    7 Burnside
    Shaw
    OL2 8LE Oldham
    Lancashire
    পরিচালক
    7 Burnside
    Shaw
    OL2 8LE Oldham
    Lancashire
    BritishUk Sales Director3382660001
    PETRIE, Nigel Fredrick Thomas Hugh
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    পরিচালক
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishDirector51578980003
    RYAN, Mark Stephen Edward
    2 Redington Close
    Worsley
    M28 1UJ Manchester
    পরিচালক
    2 Redington Close
    Worsley
    M28 1UJ Manchester
    BritishCompany Director61915760002
    SPENCER, Kathryn Margaret
    The Hollies Browns Lane
    SK9 2BR Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    The Hollies Browns Lane
    SK9 2BR Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director58744980001
    SPROTT, David
    Karinya 1 High Pell Gate Barns
    Cartmel Road
    LA11 7QX Grange Over Sands
    Cumbria
    পরিচালক
    Karinya 1 High Pell Gate Barns
    Cartmel Road
    LA11 7QX Grange Over Sands
    Cumbria
    BritishCertified Accountant106628420001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    LEGACY COMPANY THREE LTD. এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite guarantee and mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the finance documents (as defined in the debenture) and/or on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৮ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ এপ্রি, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ এপ্রি, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুন, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0