LEGACY COMPANY THREE LTD.
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | LEGACY COMPANY THREE LTD. |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | 02760037 |
এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
সৃষ্টির তারিখ | |
বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
LEGACY COMPANY THREE LTD. এর উদ্দেশ্য কী?
- নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম
LEGACY COMPANY THREE LTD. কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich Cheshire England |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
LEGACY COMPANY THREE LTD. এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
---|---|---|
DEDICATED MICROS LIMITED | ২৯ মার্চ, ১৯৯৩ | ২৯ মার্চ, ১৯৯৩ |
NORTH CENTRAL CENTRAL SERVICES LIMITED | ২৯ অক্টো, ১৯৯২ | ২৯ অক্টো, ১৯৯২ |
LEGACY COMPANY THREE LTD. এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
শেষ হিসাব | |
---|---|
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ ডিসে, ২০১৫ |
LEGACY COMPANY THREE LTD. এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?
বার্ষিক রিটার্ন |
|
---|
LEGACY COMPANY THREE LTD. এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||||||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||||||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 3 পৃষ্ঠা | DS01 | ||||||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি | 2 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
৩১ মে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Michael James Newton-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||||||
১৮ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Pauline Anne Norstrom এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
১৭ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
১৭ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Helen Pamela Doroszkiewicz এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM02 | ||||||||||||||
১২ মার্চ, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Unit 1200 Daresbury Park Daresbury Warrington WA4 4HS থেকে No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||||||
পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ জুন, ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত | 1 পৃষ্ঠা | AA01 | ||||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২৯ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 পৃষ্ঠা | SH20 | ||||||||||||||
২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ
| 4 পৃষ্ঠা | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 পৃষ্ঠা | CAP-SS | ||||||||||||||
রেজুলেশনগুলি Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২৯ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র Company name changed dedicated micros LIMITED\certificate issued on 11/03/14 | 3 পৃষ্ঠা | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২৯ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
২৪ অক্টো, ২০১৩ তারিখে Mr Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২৯ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২৯ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||||||
সচিব হিসাবে Mrs Helen Pamela Doroszkiewicz-এর নিয়োগ | 1 পৃষ্ঠা | AP03 | ||||||||||||||
LEGACY COMPANY THREE LTD. এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWTON, Michael James | পরিচালক | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | England | British | Director | 24712770003 | ||||
BANNISTER, Stephen David | সচিব | Cock Lane Farm Warrington Road, Great Budworth CW9 6HB Northwich Cheshire | British | 67739860001 | ||||||
BENTLEY-BUCHANAN, Sarah | সচিব | Strines Road Strines SK6 7GA Stockport 180 Cheshire United Kingdom | British | 135492410001 | ||||||
DOROSZKIEWICZ, Helen Pamela | সচিব | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | 164871050001 | |||||||
JOHNSON, Karen Louise | সচিব | 18 Colwyn Road Bramhall SK7 2JQ Stockport Cheshire | British | 60983560001 | ||||||
SPROTT, David | সচিব | Karinya 1 High Pell Gate Barns Cartmel Road LA11 7QX Grange Over Sands Cumbria | British | Certified Accountant | 106628420001 | |||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | কর্পোরেট মনোনীত সচিব | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
BANNISTER, Stephen David | পরিচালক | Cock Lane Farm Warrington Road, Great Budworth CW9 6HB Northwich Cheshire | British | Director | 67739860001 | |||||
BARLOW, James | পরিচালক | 15 Aspenwood Close Marple SK6 6NU Stockport Cheshire | United Kingdom | British | Managing Director | 21095060001 | ||||
CLAYTON JONES, Andrea Jayne | পরিচালক | 1 Venables Way High Lea WA16 6LY Knutsford Cheshire | British | Company Director | 15214320001 | |||||
DRENT, Ivo | পরিচালক | Korbeeklosestraat 16 Bierbeek 3360 FOREIGN Belgium | Belgian | European Sales Director | 58744920001 | |||||
DUSARA, Paresh Devchand | পরিচালক | Park Cottage Wrenshot Lane, High Legh WA16 6PG Knutsford Cheshire | England | British | Purchasing Director | 64177820001 | ||||
ELLIOTT, John Martyn | পরিচালক | 8 Spindlepoint Drive Worsley M28 7GL Manchester | British | Company Director | 56423870001 | |||||
FAWCETT, Michael Alan | পরিচালক | 94 Mottram Old Road SK15 2TE Stalybridge Cheshire | British | Accountant | 38913590002 | |||||
FINN, Andrew Patrick | পরিচালক | Treetops 241 Bramhall Moor Road SK7 5JL Hazel Grove Stockport Cheshire | England | British | Director | 169499300001 | ||||
HUMPHREY, John Eugene | পরিচালক | 23 Whitland Avenue BL1 5FB Bolton Greater Manchester | England | British | Managing Director | 119278130001 | ||||
KULLESEID, Peter James | পরিচালক | 9 Rooklands Scotter DN21 3TT Gainsborough Lincolnshire | British | Director | 56139320001 | |||||
NEWTON, Michael James | পরিচালক | Frandley House Warrington Road Antrobus CW9 6JB Nortwich Cheshire | England | British | Director | 24712770003 | ||||
NORSTROM, Pauline Anne | পরিচালক | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | England | British | Director | 148506110001 | ||||
O'DOWD, Christopher John | পরিচালক | Rathbane Princes Gate HX3 0EH Halifax Yorkshire | England | Irish | Director | 92850910001 | ||||
OLIVER, Graeme William | পরিচালক | 7 Burnside Shaw OL2 8LE Oldham Lancashire | British | Uk Sales Director | 3382660001 | |||||
PETRIE, Nigel Fredrick Thomas Hugh | পরিচালক | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | United Kingdom | British | Director | 51578980003 | ||||
RYAN, Mark Stephen Edward | পরিচালক | 2 Redington Close Worsley M28 1UJ Manchester | British | Company Director | 61915760002 | |||||
SPENCER, Kathryn Margaret | পরিচালক | The Hollies Browns Lane SK9 2BR Wilmslow Cheshire | England | British | Finance Director | 58744980001 | ||||
SPROTT, David | পরিচালক | Karinya 1 High Pell Gate Barns Cartmel Road LA11 7QX Grange Over Sands Cumbria | British | Certified Accountant | 106628420001 | |||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
LEGACY COMPANY THREE LTD. এর কোনো চার্জ আছে কি?
শ্রেণীবিন্যাস | তারিখ | স্থিতি | বিস্তারিত | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and mortgage debenture | তৈরি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৯৭ ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯৭ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the finance documents (as defined in the debenture) and/or on any account whatsoever | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Debenture | তৈরি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯৫ ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৫ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Mortgage debenture | তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুন, ১৯৯৪ ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৯৪ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
|
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0