GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02762842
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    KEEPEAGER LIMITED০৯ নভে, ১৯৯২০৯ নভে, ১৯৯২

    GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ ডিসে, ২০১৫ থেকে ৩০ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২২ অক্টো, ২০১৫ তারিখে Mr Colin Edward Lewis-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২২ অক্টো, ২০১৫ তারিখে Mr Giles Henry Sharp-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২২ অক্টো, ২০১৫ তারিখে Joanne Elizabeth Massey-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ২৩ অক্টো, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG থেকে Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WPপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ অক্টো, ২০১৫

    ২৩ অক্টো, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jon William Mortimore এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ জানু, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Giles Sharp-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১২ ডিসে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Neil Fitzsimmons এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ 2 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 10 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 11 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ১৫ ডিসে, ২০১৪ তারিখে Joanne Elizabeth Massey-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ অক্টো, ২০১৪

    ২০ অক্টো, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Elizabeth Catchpole এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Jon William Mortimore-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ অক্টো, ২০১৩

    ১৮ অক্টো, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    সচিব
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147807760001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    পরিচালক
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    পরিচালক
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    সচিব
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    সচিব
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    TAYLOR, David John
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    সচিব
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    British136521790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATKINSON, David Charles
    7 Blenheim Court
    Wellesley Road
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    পরিচালক
    7 Blenheim Court
    Wellesley Road
    SM2 5BW Sutton
    Surrey
    British35117370001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    পরিচালক
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    পরিচালক
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    EnglandBritish98235420004
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    পরিচালক
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    পরিচালক
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    পরিচালক
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MARSHALL, Louis Daniel
    22 Abigail Crescent
    ME5 9DZ Walderslade
    Kent
    পরিচালক
    22 Abigail Crescent
    ME5 9DZ Walderslade
    Kent
    United KingdomBritish152847400001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    পরিচালক
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United KingdomBritish207729000002
    NESBITT, Peter Victor
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    পরিচালক
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    British27564990001
    PEDLEY, Mark Jonathan
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Morningdale
    421 Weedon Road
    NN5 4EX Northampton
    Northamptonshire
    British112119110001
    WEST, William Samuel
    Jonel Highview Lane
    Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    পরিচালক
    Jonel Highview Lane
    Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    British35383900001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GLADEDALE EXECUTIVE HOMES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a pymore bridport in the county of dorset t/n DT202773, DT207080, DT229615 & DT207062. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ নভে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    First party commercial legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ সেপ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H little hamonds farm london road burgess hill east sussex t/no SX116439 fixed charge all buildings and other structures fixed charge asigns of goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২০ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a moorfields mill lane south holmwood surrey t/n SY599533, allbuildings structures items plant and machinery, goodwill, rentals claims under insurance policies relating or fixed to the property, floating charge over unattached plant machinery chattels and goods in connection with the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Assignment of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Lloyd's life policy no 551/N3AA079 together with all rights, title, interests and accreations thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ সেপ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    58 maywater close sanderstead surrey t/no: TGL304052. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২০ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land k/a 5 and 5A hawthorne place and 9 linden place epsom surrey t/n's SY643611,SY364122 and SY80306. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৯ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Life policy assignation
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুন, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Lloyds underwriters :cygnet life policy no.:risk no.N3AAO79 together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০২ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৭ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a santa tecla stanstead caterham surrey t/n SY399840. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৭ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0