TJH GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTJH GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02788607
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TJH GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7415) /

    TJH GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TJH GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CITY MANOR LIMITED১০ ফেব, ১৯৯৩১০ ফেব, ১৯৯৩

    TJH GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১১

    TJH GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    4 পৃষ্ঠাMG02

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৮ নভে, ২০১১

    RES15

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ জুন, ২০১১

    ০৯ জুন, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ০৬ জুন, ২০১০ তারিখে John David Holden-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০৬ জুন, ২০১০ তারিখে John Clement Kay-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৬ জুন, ২০১০ তারিখে Miss Kathryn Revitt-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৬ জুন, ২০১০ তারিখে Mr Mark Lorimer Widders-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা403a

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    10 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    11 পৃষ্ঠা395

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Approve board minutes 26/02/2009
    RES13

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    TJH GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HOLDEN, John David
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    সচিব
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    British137210330001
    KAY, John Clement
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    পরিচালক
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    EnglandBritish27891540001
    REVITT, Kathryn
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    পরিচালক
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritish49315020001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    পরিচালক
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    EnglandBritish2272770002
    KAY, John Clement
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    সচিব
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    British27891540001
    LIVESEY, Frederick Joseph
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    সচিব
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    British32145610004
    SIMMONDS, Gordon Graham
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    সচিব
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    British34446930003
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    সচিব
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    British83024660001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    সচিব
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    British2272770002
    GRAVITAS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    25-31 Moorgate
    London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    25-31 Moorgate
    London
    900007520001
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    পরিচালক
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish65090920001
    JACKSON, Nigel Spencer
    27 St Johns Road
    NW11 0PE London
    পরিচালক
    27 St Johns Road
    NW11 0PE London
    EnglandBritish53249050001
    JOHNS, Michael Stephen Mackelcan
    22 Bowerdean Street
    London
    মনোনীত পরিচালক
    22 Bowerdean Street
    London
    British900007510001
    KAY, John Clement
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    পরিচালক
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish27891540001
    KENT-LEMON, Nigel William
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    পরিচালক
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    British6467990001
    LIVESEY, Frederick Joseph
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    পরিচালক
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    British32145610004
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    পরিচালক
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    United KingdomBritish83024660001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish2272770002

    TJH GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties or Any Person Appointed as Security Trustee from Time to Time in Accordance Withe the Terms of the Facility Agreement
    ব্যবসায়
    • ০৯ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ মার্চ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental debenture between the company and the governor and company of the bank of scotland as agent and security trustee for the secured parties (the security trustee)
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to the supplemental debenture and any of the financing documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company assigned (as continuing security in favour of the security trustee) (as defined) with full title guarantee by way of security all of its rights title and interest (both present and future) in all and each of the acquisition documents (as defined).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge and any of the financing documents (as therein defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Secured Parties (As Therein Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৯ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0