TVAC-THE VEHICLE APPLICATION CENTRE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTVAC-THE VEHICLE APPLICATION CENTRE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02806459
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TVAC-THE VEHICLE APPLICATION CENTRE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (3410) /
    • (9305) /

    TVAC-THE VEHICLE APPLICATION CENTRE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Woodborough Road
    NG1 3FG Nottingham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TVAC-THE VEHICLE APPLICATION CENTRE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    USUALCHECK SERVICES LIMITED০২ এপ্রি, ১৯৯৩০২ এপ্রি, ১৯৯৩

    TVAC-THE VEHICLE APPLICATION CENTRE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০০৮

    TVAC-THE VEHICLE APPLICATION CENTRE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ১৬ মে, ২০১১ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    23 পৃষ্ঠা2.24B

    ২৭ মে, ২০১১ তারিখে প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    23 পৃষ্ঠা2.35B

    legacy

    3 পৃষ্ঠাLQ01

    ১৭ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    17 পৃষ্ঠা2.24B

    পরিচালক হিসাবে Raymond Flynn এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ১৭ জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    26 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ১৭ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    13 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    10 পৃষ্ঠা2.16B

    ১৭ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    15 পৃষ্ঠা2.24B

    ক্রেডিটর কমিটির গঠনের সংশোধিত শংসাপত্র

    1 পৃষ্ঠা2.26B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    62 পৃষ্ঠা2.23B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    61 পৃষ্ঠা2.17B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    17 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    শেয়ারের অধিকার বা নাম পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES12
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    TVAC-THE VEHICLE APPLICATION CENTRE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    LAVENDER, Michael David
    Forty Hill House
    EN2 9EU Forty Hill
    Middlesex
    সচিব
    Forty Hill House
    EN2 9EU Forty Hill
    Middlesex
    British149181030001
    SHANNON, Marcus John
    48 Loughanmore Road
    BT41 2HN Dunadry
    County Antrim
    N Ireland
    পরিচালক
    48 Loughanmore Road
    BT41 2HN Dunadry
    County Antrim
    N Ireland
    United KingdomBritishDirector108366960001
    MOON, Stephen Edward
    Hockley Lane
    CV37 7SS Ettington
    Forge Cottage
    Warwickshire
    সচিব
    Hockley Lane
    CV37 7SS Ettington
    Forge Cottage
    Warwickshire
    BritishDirector158469620001
    SINGLETON, James Albert
    62 Hazelhurst Road
    Worsley
    M28 2SQ Manchester
    Lancashire
    সচিব
    62 Hazelhurst Road
    Worsley
    M28 2SQ Manchester
    Lancashire
    BritishConsultant116063600001
    SMITH, Elisabeth Jean
    Jubilee Cottage
    Bradshaw Lane Mawdesley
    L40 3SE Omskirk
    Lancashire
    সচিব
    Jubilee Cottage
    Bradshaw Lane Mawdesley
    L40 3SE Omskirk
    Lancashire
    British97649770001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DRINKWATER, Oliver James
    Roedean
    Whiteacre Lane
    BB7 9BJ Whalley
    Lancashire
    পরিচালক
    Roedean
    Whiteacre Lane
    BB7 9BJ Whalley
    Lancashire
    BritishEngineering77131690001
    FLYNN, Raymond Francis
    66 Kiln Park
    BT39 0BB Templepatrick
    County Antrim
    Northern Ireland
    পরিচালক
    66 Kiln Park
    BT39 0BB Templepatrick
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishChartered Acountant119131330001
    MCHUGH, Stephen Andrew
    68a Sleaford Road
    NG34 9QW Heckington
    Lincolnshire
    পরিচালক
    68a Sleaford Road
    NG34 9QW Heckington
    Lincolnshire
    United KingdomBritishDirector79505350001
    MOON, Stephen Edward
    Hockley Lane
    CV37 7SS Ettington
    Forge Cottage
    Warwickshire
    পরিচালক
    Hockley Lane
    CV37 7SS Ettington
    Forge Cottage
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector158469620001
    SINCLAIR, Eric Thomas
    13 Stapleton Avenue
    BL1 5ES Bolton
    Lancashire
    পরিচালক
    13 Stapleton Avenue
    BL1 5ES Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritishAccountant2100840001
    SMITH, Elisabeth Jean
    Jubilee Cottage
    Bradshaw Lane Mawdesley
    L40 3SE Omskirk
    Lancashire
    পরিচালক
    Jubilee Cottage
    Bradshaw Lane Mawdesley
    L40 3SE Omskirk
    Lancashire
    BritishCompany Secretary97649770001
    SMITH, Gary Ian
    Jubilee Cottage
    Bradshaw Lane
    L40 3SE Mawdesley
    Lancashire
    পরিচালক
    Jubilee Cottage
    Bradshaw Lane
    L40 3SE Mawdesley
    Lancashire
    EnglandEnglishDirector35800360001
    SMITH, Rebecca Jane
    Jubilee Cottage
    Bradshaw Lane Mawdesley
    L40 3SE Omskirk
    Lancashire
    পরিচালক
    Jubilee Cottage
    Bradshaw Lane Mawdesley
    L40 3SE Omskirk
    Lancashire
    BritishSales & Marketing97649610001
    SMITH, Ryan James
    Jubilee Cottage
    Bradshaw Lane Mawdesley
    L40 3SE Omskirk
    Lancashire
    পরিচালক
    Jubilee Cottage
    Bradshaw Lane Mawdesley
    L40 3SE Omskirk
    Lancashire
    BritishChef97649560001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    TVAC-THE VEHICLE APPLICATION CENTRE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H plot 12 lancashire business park leyland lancashire containing in whole 1.41 acres or thereabouts forming part of the land comprised in t/no LA716891 and registered with t/no LA909557.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • 2০৭ জুন, ২০১১একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (LQ01)
      • মামলা নম্বর 2
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুল, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Assetco PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুল, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 12 lancashire enterprise business park centurion way leyland lancashire t/no LA909557.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Davenham Trade Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Lancashire enterprise business park centurion way leyland lancashire t/n LA716891.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Davenham Trade Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Invoice finance agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company with full title guarantee hereby charges by way of all book and other debts, revenues and claims both present and future and all things in action due or owing, or which may be due and owing to or purchased or owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Davenham Trade Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Davenham Trade Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £550,000,00 due or to become due from the company to
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot 12 lancashire enterprise business park centurion way leyland preston t/no L. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dickinson Keynon Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge all specified debts and other debts and floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cattles Invoice Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জানু, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a land at lancashire enterprise business park centurion way leyland preston lancashire t/n LA716891. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ জানু, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over a building agreement of even date made between lancashire county enterprises (industrial development) limited and the company
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    An assignment of all the company's benefit of the building agreement relating to property situate at plot 12 lancashire enterprises business park leyland lancashire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    TVAC-THE VEHICLE APPLICATION CENTRE LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৭ মে, ২০১১প্রশাসন শেষ
    ১৮ ডিসে, ২০০৮প্রশাসন শুরু
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    William Kenneth Dawson
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    অভ্যাসকারী
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    John Charles Reid
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    অভ্যাসকারী
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    2রিসিভার/ম্যানেজার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Richard Keith Rowe
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    রিসিভার ম্যানেজার
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Anthony Lavern Spencer
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    রিসিভার ম্যানেজার
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0