CA 2010 PLC

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCA 2010 PLC
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02808331
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CA 2010 PLC এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7415) /

    CA 2010 PLC কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Valley
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CA 2010 PLC এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CHARLTON ATHLETIC PLC০৬ জানু, ১৯৯৪০৬ জানু, ১৯৯৪
    YPCS 25 P.L.C.১৩ এপ্রি, ১৯৯৩১৩ এপ্রি, ১৯৯৩

    CA 2010 PLC এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০০৯

    CA 2010 PLC এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পরিচালক হিসাবে Richard Hatter এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে David White এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Sale of entire iss share cap/sec 190(1) 23/08/2010
    RES13
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed charlton athletic PLC\certificate issued on 10/09/10
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২৩ আগ, ২০১০

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    পরিচালক হিসাবে Derek Chappell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে David Hughes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Robert Whitehand এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে David Sumners এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    পরিচালক হিসাবে Stephen Kavanagh-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ০৫ আগ, ২০১০ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 31,947,961.5
    8 পৃষ্ঠাSH01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের বাল্ক তালিকা সহ

    26 পৃষ্ঠাAR01

    ১৫ জানু, ২০১০ তারিখে Richard Alan Murray Obodynski-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    পৃষ্ঠাANNOTATION

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Re section 560 ca 2006 30/12/2009
    RES13

    CA 2010 PLC এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    VERTEX LAW (CO SECRETARIAL) LIMITED
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UD West Malling
    23
    Kent
    কর্পোরেট সচিব
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UD West Malling
    23
    Kent
    102565320003
    BUTLER-GALLIE, Stuart
    Bethersden
    TN26 3EW Ashford
    Baylisden House
    Kent
    পরিচালক
    Bethersden
    TN26 3EW Ashford
    Baylisden House
    Kent
    EnglandBritish96783000001
    KAVANAGH, Stephen Andrew
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    The Valley
    পরিচালক
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    The Valley
    EnglandBritish153739440001
    MURRAY OBODYNSKI, Richard Alan
    66-70 Coombe Road
    KT3 4QW New Maldon
    Nunn Hayward
    Surrey
    পরিচালক
    66-70 Coombe Road
    KT3 4QW New Maldon
    Nunn Hayward
    Surrey
    EnglandBritish46792500008
    FULLER, Jonathan Tom Telford
    Rose Cottage
    Twitton Lane
    TN14 5JS Otford
    Kent
    সচিব
    Rose Cottage
    Twitton Lane
    TN14 5JS Otford
    Kent
    British52304380001
    ROBINSON, Keith Marshall
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    সচিব
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    British8282250001
    BRACHERS LIMITED
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    কর্পোরেট সচিব
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    80957680001
    DAVIES LAVERY COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    কর্পোরেট সচিব
    Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    87634940001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    ALWEN, Roger Norman
    11 Bywater Street
    Chelsea
    SW3 4XD London
    পরিচালক
    11 Bywater Street
    Chelsea
    SW3 4XD London
    British14306470002
    BONE, Gregory Peter
    17 Brassey Hill
    Limpsfield
    RH8 0ES Oxted
    Surrey
    পরিচালক
    17 Brassey Hill
    Limpsfield
    RH8 0ES Oxted
    Surrey
    British26854940002
    CHAPPELL, Derek Guy
    13 Walton Place
    SW3 1RJ London
    পরিচালক
    13 Walton Place
    SW3 1RJ London
    EnglandBritish32697520004
    CLARKE, Stephen Thomas
    20 Porcupine Close
    Mottingham
    SE9 3AE London
    পরিচালক
    20 Porcupine Close
    Mottingham
    SE9 3AE London
    United KingdomBritish33772930001
    COLLINS, Richard Denis
    33b Garden Road
    BR1 3LU Bromley
    Kent
    পরিচালক
    33b Garden Road
    BR1 3LU Bromley
    Kent
    British1811300001
    FRANKLIN, Gideon Benjamin Cecil
    22 Ringmore Rise
    SE23 3DE London
    পরিচালক
    22 Ringmore Rise
    SE23 3DE London
    United KingdomBritish69257060003
    GRADE, Michael Ian
    6 Westover Road
    SW18 2RG London
    পরিচালক
    6 Westover Road
    SW18 2RG London
    EnglandBritish71289920004
    HALLETT, Brian James
    39 Old Garden Close
    Locks Heath
    SO31 6RN Southampton
    Hampshire
    পরিচালক
    39 Old Garden Close
    Locks Heath
    SO31 6RN Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish9715270001
    HATTER, Maurice, Sir
    38 Queens Grove
    NW8 6HH London
    পরিচালক
    38 Queens Grove
    NW8 6HH London
    EnglandBritish36506710001
    HATTER, Richard Mark
    Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UJ London
    54
    পরিচালক
    Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UJ London
    54
    EnglandEnglish67030840002
    HUGHES, David John
    Sterling Street
    SW7 1HN London
    8
    পরিচালক
    Sterling Street
    SW7 1HN London
    8
    EnglandBritish49400910005
    HUGHES, David John
    Vitol Sa
    Bowater House 68 Knightsbridge
    SW1X 7LT London
    পরিচালক
    Vitol Sa
    Bowater House 68 Knightsbridge
    SW1X 7LT London
    British49400910001
    NORRIS, Craig Victor
    156 Humber Road
    Blackheath
    SE3 7EF London
    পরিচালক
    156 Humber Road
    Blackheath
    SE3 7EF London
    British43819750002
    ROBINSON, Keith Marshall
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    পরিচালক
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    United KingdomBritish8282250001
    SIMONS, Martin Alan
    48 Shooters Hill Road
    Blackheath
    SE3 7BG London
    পরিচালক
    48 Shooters Hill Road
    Blackheath
    SE3 7BG London
    British15777410001
    STEVENS, Michael Clifford
    Northside 36 Southborough Road
    Bickley
    BR1 2EB Bromley
    Kent
    পরিচালক
    Northside 36 Southborough Road
    Bickley
    BR1 2EB Bromley
    Kent
    British25614630001
    SUMNERS, David Colin, Dr
    The Old Vicarage
    2 Mountfort Crescent
    N1 1JW London
    পরিচালক
    The Old Vicarage
    2 Mountfort Crescent
    N1 1JW London
    United KingdomBritish47150540002
    UFTON, Derek Gilbert
    88 Madeira Avenue
    BR1 4AS Bromley
    Kent
    পরিচালক
    88 Madeira Avenue
    BR1 4AS Bromley
    Kent
    British15366180001
    WHITE, David
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    The Briars
    Kent
    পরিচালক
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    The Briars
    Kent
    United KingdomBritish138647910001
    WHITEHAND, Robert Charles
    Dunstall Priory Shoreham Road
    Shoreham
    TN14 7UE Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Dunstall Priory Shoreham Road
    Shoreham
    TN14 7UE Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish54419430001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001

    CA 2010 PLC এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • David Hughes
    ব্যবসায়
    • ২৯ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • David Sumners
    ব্যবসায়
    • ২৯ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ সেপ, ২০০৯
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • David White
    ব্যবসায়
    • ২৯ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ সেপ, ২০০৯
    • ২৫ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Sir Maurice Hatter
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুন, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Richard Alan Murray
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Derek Chappell
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 56 Developments LLP
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the to the bondholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Richard Alan Murray and Derek Chappell
    ব্যবসায়
    • ০৮ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জানু, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Richard Alan Murray
    ব্যবসায়
    • ১০ জানু, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bolistrom Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Sir Maurice Hatter
    ব্যবসায়
    • ০৯ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • David Colin Sumners
    ব্যবসায়
    • ০৯ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Robert Charles Whitehand
    ব্যবসায়
    • ০৯ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Derek Chappell
    ব্যবসায়
    • ০৯ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Legal mortgage over the property; fixed charge over f/h & l/h property both present and future together with all fixtures and its goodwill; a floating charge over the undertaking and all its (other) property and assets whatsoever.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0