CAVENDISH GEARED II LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCAVENDISH GEARED II LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02847571
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CAVENDISH GEARED II LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    CAVENDISH GEARED II LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CAVENDISH GEARED II LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০২২

    CAVENDISH GEARED II LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০৭ ডিসে, ২০২২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.50
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Reducing share premium account 05/12/2022
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ০৩ নভে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Charles Mcnuff এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ নভে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gavin Bergin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ নভে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alexander Christofis এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ আগ, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Charles John Middleton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alexander Christofis-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ ডিসে, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Bruce Michael James এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ১৯ আগ, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৯ মার্চ, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Gavin Bergin-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৫ অক্টো, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Nick Taunt-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১১ সেপ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Tom Robson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ আগ, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ জানু, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Josephine Hayman-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ জানু, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Tom Robson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৯ আগ, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    CAVENDISH GEARED II LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর8992198
    187856670001
    HAYMAN, Josephine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant266797860001
    TAUNT, Nick
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant275050860001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    সচিব
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    BritishCompany Secretary32809000002
    BURGESS, Graeme
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    সচিব
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    British102349020001
    CADER, Tariq Azad
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    সচিব
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    British42841550001
    DUNN, Lisa
    Crossroads Farm
    Haversham
    MK19 7DS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    সচিব
    Crossroads Farm
    Haversham
    MK19 7DS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishSolicitor70468680001
    EKPO, Ndiana
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    সচিব
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    সচিব
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    পরিচালক
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    পরিচালক
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BERGIN, Gavin
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary251327820001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    পরিচালক
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BROOKSHAW, Oliver Chitty
    Thorpe Underwood Farm
    Thorpe Underwood
    NN6 9PA Northampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Thorpe Underwood Farm
    Thorpe Underwood
    NN6 9PA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishSolicitor32299820001
    CADER, Tariq Azad
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    পরিচালক
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    BritishAccoutant42841550001
    CARTER, Simon Geoffrey
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    পরিচালক
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CHRISTOFIS, Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishShared Services Director294162810001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    পরিচালক
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    BritishChartered Secretary78691990001
    COOK, Kevin William
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    BritishChartered Quantity Surveyor16914120001
    DAVIES, Raymond John
    Gables
    Common Lane
    EX12 3EY Beer
    East Devon
    পরিচালক
    Gables
    Common Lane
    EX12 3EY Beer
    East Devon
    BritishDirector2763140001
    DUNN, Lisa
    Crossroads Farm
    Haversham
    MK19 7DS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Crossroads Farm
    Haversham
    MK19 7DS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritishSolicitor70468680001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    পরিচালক
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    GLEESON, Dermot James
    Hook Farm White Hart Lane
    Wood Street Village
    GU3 3EA Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Hook Farm White Hart Lane
    Wood Street Village
    GU3 3EA Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector20983460001
    GROSE, Benjamin Toby
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    পরিচালক
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    পরিচালক
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3079890002
    HAMILTON, Laura Louise
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    পরিচালক
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    AmericanExecutive Manager73545680001
    HERRTAGE, Nicholas Guy Greville
    24 Ellerton Road
    SW18 3NN London
    পরিচালক
    24 Ellerton Road
    SW18 3NN London
    EnglandBritishCompany Director56330650002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    পরিচালক
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Secretariat226746900001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    পরিচালক
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KEARTON GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    পরিচালক
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector16914130001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    পরিচালক
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    পরিচালক
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001

    CAVENDISH GEARED II LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    London And Henley (Uk) Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland & Wales
    নিবন্ধন নম্বর3576158
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    London And Henley (Uk) Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Company Limited By Shares
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।

    CAVENDISH GEARED II LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge over beneficial interest
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities, due or to become due from the borrower or the company to the beneficiaries under the finance documents or on any account whatsoever (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of security assignment each of the following including all rights of enforcement of the same. 1. the property being 22A crescent road london N8 freehold and flat 1 and 9 t/no EGL215761 and flats 2,3,6,7,10,11,12,13 and 16 t/nos EGL290049,EGL290050,EGL302155,EGL302154,EGL284333,EGL292411,EGL302157,EGL284220 and EGL284219 respectively. 2.The rents 3.the trust deed.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abbey National Treasury Services PLC (As Security Trustee for Thebeneficiaries Pursuant to the Facility Agreement)
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    In favour of the chargee all monies and liabilities due owing or incurred from london & henley UK limited (the "borrower") or the company to the beneficiaries under the finance documents or otherwise on any account whatsoever (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Abbey National Treasury Services Plcacting as Trustee for the Beneficiaries Under the Facility Agreement ("the Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ সেপ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    89 inverness terrace london t/no: LN130210. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২১ সেপ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ আগ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ আগ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage over all the f/h property k/a 119 & 121 east hill,wandsworth london SW18 t/nos.403667 And 403668. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 22 crescent road, crouch end london t/no: EGL125761; all buildings and other structures goodwill all plant machinery and other items assignment of rents. Floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a flats 6,7, 11 & 12 orchard house, 22A crescent road crouch end london t/nos: EGL302155 EGL302154 EGL292411 & EGL30257; all buildings and other structures goodwill all plant machinery and other items assignment of rents. Floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a 91A fernhead road london t/no: NGL360844; all buildings and other structures goodwill all plant machinery and other items assignment of rents. Floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a part of 330 westbourne park road, kensington london; all buildings and other structures goodwill all plant machinery and other items assignment of rents. Floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ফেব, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 163 trinity road london t/no TGL107537 all buidlings & structures and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জানু, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the f/h property k/a 272,274 and 276 wandsworth bridge road fulham lonodn SW6 t/n BGL2272 and by way of fixed charge all buildings and other structures by way of fixed charge any goodwill all plant machinery and other chattels and the proceeds of any claims made under the insurances by way of assignment the rental sums and by way of floating charge all unnatached plant machinery chattels and goods.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৮ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 55 queen's gardens, london W2 t/no. NGL724928. Fixed charges over all buildings and other structures fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant machinery and other chattels affixed to the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. Floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property. Assignment of the rental sums.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ সেপ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 184-188 north gower street, london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a flat 16 orchard house, 22A crescent road, london t/no. Egl 284219. fixed charge over all buildings and other structures fixed to the property. Fixed charge over any goodwill relating to the property.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a flat 13 orchard house, 22A crescent road, london t/no. EGL284220. Fixed charge over all buildings and other structures fixed to the property. Fixed charge over any goodwill relating to the property.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a flat 10 orchard house, 22A crescent road, london t/no. EGL284333. Fixed charge over all buildings and other structures fixed to the property. Fixed charge over any goodwill relating to the property.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a flat 3 orchard house, 22A crescent road, london t/no. EGL290050. Fixed charge over all buildings and other structures fixed to the property. Fixed charge over any goodwill relating to the property.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a flat 2 orchard house, 22A crescent road, london t/no. EGL290049. Fixed charge over all buildings and other structures fixed to the property. Fixed charge over any goodwill relating to the property.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 54 wellesley road chiswick london W4 t/no.MX25903 and all buildings and other structures and goodwill. Fixed and floating charges over all plant machinery and other chattels.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H-1 compayne gardens hampstead london NW6 t/n-NGL247500. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to the property; by way of fixed charge any goodwill relating to the property or the business or undertaking conducted at the property;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ৩০ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H-15 fairmead road upper holloway london N19 t/n-LN63781. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to the property; by way of fixed charge any goodwill relating to the property or the buisness or undertaking conducted at the property;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ৩০ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h property k/a 32A sheringham road london N7 t/no 384257 and with A. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 1 hides street london N7 t/no 383036 and with A. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a 3 hides street london t/no 383023 and with A. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 1 birnam road london t/no ngl 239629 and with A. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0