GREENCORE PF LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGREENCORE PF LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02848990
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GREENCORE PF LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • প্রস্তুত খাবার এবং খাবার উৎপাদন (10850) / উৎপাদন

    GREENCORE PF LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GREENCORE PF LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    GREENCORE PF PLC১২ অক্টো, ২০০৫১২ অক্টো, ২০০৫
    PARAMOUNT FOODS PLC০১ জুল, ১৯৯৭০১ জুল, ১৯৯৭
    CANADIAN PIZZA PLC১৪ অক্টো, ১৯৯৩১৪ অক্টো, ১৯৯৩
    NOVA 1993 LIMITED২৮ আগ, ১৯৯৩২৮ আগ, ১৯৯৩

    GREENCORE PF LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৬ সেপ, ২০১৪

    GREENCORE PF LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    12 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২৬ এপ্রি, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    11 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৬ এপ্রি, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    11 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৬ এপ্রি, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    14 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৬ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    12 পৃষ্ঠা4.68

    ২২ মে, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Greencore Group Uk Centre Midland Way Barlborough Links Bus Pk, Barlborough Chesterfield S43 4XA থেকে Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3ADপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৭ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    9 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    পূর্ণ হিসাব ২৬ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ আগ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ সেপ, ২০১৪

    ০১ সেপ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 190.24216
    SH01

    ০১ আগ, ২০১৪ তারিখে Patrick Francis Coveney-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১১ জুল, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 190.24
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৭ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ আগ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Diane Walker এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr. Alan Richard Williams-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    দ্বিতীয় দায়ের AP01 এর যা পূর্বে কোম্পানিজ হাউসে জমা দেওয়া হয়েছিল

    5 পৃষ্ঠাRP04
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ১৭ এপ্রি, ২০১৩A second filed AP01 for Jolene Gacquin

    পূর্ণ হিসাব ২৮ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Ms. Jolene Anna Gacquin-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ১৭ এপ্রি, ২০১৩A second filed AP01 was registered on 17/04/2013

    পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি থেকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পুনঃ নিবন্ধনের শংসাপত্র

    1 পৃষ্ঠাCERT10

    GREENCORE PF LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    EVANS, Michael
    Midland Way
    Barlborough
    S43 4XA Chesterfield
    Barlborough Links Business Park
    Derbyshire
    United Kingdom
    সচিব
    Midland Way
    Barlborough
    S43 4XA Chesterfield
    Barlborough Links Business Park
    Derbyshire
    United Kingdom
    156862770001
    COVENEY, Patrick Francis
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    Santry
    No 2
    Dublin 9
    Ireland
    পরিচালক
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    Santry
    No 2
    Dublin 9
    Ireland
    IrelandIrish143778240002
    EVANS, Michael
    Midland Way
    Barlborough Links Business Park
    S43 4XA Barlborough
    Uk Centre
    Chesterfield
    পরিচালক
    Midland Way
    Barlborough Links Business Park
    S43 4XA Barlborough
    Uk Centre
    Chesterfield
    United KingdomBritish148060720001
    GACQUIN, Jolene, Ms.
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    Santry
    No 2
    Dublin 9
    Ireland
    পরিচালক
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    Santry
    No 2
    Dublin 9
    Ireland
    IrelandIrish176835220001
    O'LEARY, Conor
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Town Wall House
    Essex
    পরিচালক
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Town Wall House
    Essex
    IrelandIrish143778250002
    WILLIAMS, Alan Richard, Mr.
    c/o Greencore Group Plc
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    Santry
    25
    Dublin9
    Ireland
    পরিচালক
    c/o Greencore Group Plc
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    Santry
    25
    Dublin9
    Ireland
    EnglandBritish137582690001
    AUSTIN, Wilfrid Anthony
    22 Parkwood Close
    WA13 0NQ Lymm
    Cheshire
    সচিব
    22 Parkwood Close
    WA13 0NQ Lymm
    Cheshire
    British18991290001
    BARRATT, William Harrison
    3 Sycamore Close
    DN22 7JP Retford
    Nottinghamshire
    সচিব
    3 Sycamore Close
    DN22 7JP Retford
    Nottinghamshire
    British100531360001
    BEARD, Simon Mark
    23 Hoyles Lane
    Cottam
    PR4 0LB Preston
    সচিব
    23 Hoyles Lane
    Cottam
    PR4 0LB Preston
    British47491740004
    BOLTON, Reginald Martin George, Dr
    1 The Manor House
    Filkins Lane
    CH3 5EP Chester
    সচিব
    1 The Manor House
    Filkins Lane
    CH3 5EP Chester
    British29215280001
    CULLEN, David
    14 Bourchier Way
    WA4 3DW Warrington
    Cheshire
    সচিব
    14 Bourchier Way
    WA4 3DW Warrington
    Cheshire
    Irish86759430002
    DAINES, Ian David
    47 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    সচিব
    47 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    British114380000001
    HYNES, Anthony Martin
    The Piggeries Hassop
    DE45 1NW Bakewell
    Derbyshire
    সচিব
    The Piggeries Hassop
    DE45 1NW Bakewell
    Derbyshire
    Irish100467690002
    RAYNARD, Angus Steele
    The Spinney
    Clipsham Road, Stretton
    LE15 7QS Oakham
    Rutland
    সচিব
    The Spinney
    Clipsham Road, Stretton
    LE15 7QS Oakham
    Rutland
    British80419200001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    BARRATT, William Harrison
    3 Sycamore Close
    DN22 7JP Retford
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    3 Sycamore Close
    DN22 7JP Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritish100531360001
    BEARD, Simon Mark
    23 Hoyles Lane
    Cottam
    PR4 0LB Preston
    পরিচালক
    23 Hoyles Lane
    Cottam
    PR4 0LB Preston
    British47491740004
    BOLTON, Reginald Martin George, Dr
    1 The Manor House
    Filkins Lane
    CH3 5EP Chester
    পরিচালক
    1 The Manor House
    Filkins Lane
    CH3 5EP Chester
    United KingdomBritish29215280001
    BOLTON, Reginald Martin George, Dr
    1 The Manor House
    Filkins Lane
    CH3 5EP Chester
    পরিচালক
    1 The Manor House
    Filkins Lane
    CH3 5EP Chester
    United KingdomBritish29215280001
    CARR, Michael Scott
    Highfield House
    Leckhamptonstead
    RG20 8QN Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Highfield House
    Leckhamptonstead
    RG20 8QN Newbury
    Berkshire
    British48047490001
    CULLEN, David
    14 Bourchier Way
    WA4 3DW Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    14 Bourchier Way
    WA4 3DW Warrington
    Cheshire
    Irish86759430002
    DAINES, Ian David
    47 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    47 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish114380000001
    DARE, Andrew Rodney
    Whitegates
    Mathon Road Colwall
    WR13 6ER Malvern
    Worcestershire
    পরিচালক
    Whitegates
    Mathon Road Colwall
    WR13 6ER Malvern
    Worcestershire
    EnglandBritish36710550002
    DIGGINES, Jonathan Brett
    Rossways
    32 Broad Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    পরিচালক
    Rossways
    32 Broad Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    British80119110001
    DILGER, David John
    Lauriston Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    Co Dublin
    Ireland
    পরিচালক
    Lauriston Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    Co Dublin
    Ireland
    Irish74455510001
    FEATHERSTONE, Alan
    48 Ridge Way
    Hixon
    ST18 0NZ Stafford
    Staffordshire
    পরিচালক
    48 Ridge Way
    Hixon
    ST18 0NZ Stafford
    Staffordshire
    British30149770001
    HYNES, Anthony Martin
    The Piggeries Hassop
    DE45 1NW Bakewell
    Derbyshire
    পরিচালক
    The Piggeries Hassop
    DE45 1NW Bakewell
    Derbyshire
    EnglandIrish100467690002
    KENNEDY, Patrick Thomas
    61 Dartmouth Square
    Dublin 6
    Ireland
    পরিচালক
    61 Dartmouth Square
    Dublin 6
    Ireland
    Irish74455540001
    KENT, Henry Lincoln
    Regency House
    Towers Road Poynton
    SK12 1DD Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    Regency House
    Towers Road Poynton
    SK12 1DD Stockport
    Cheshire
    British5575330003
    KENT, Ian Michael
    56 Woolley Avenue
    Poynton
    SK12 1XU Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    56 Woolley Avenue
    Poynton
    SK12 1XU Stockport
    Cheshire
    British7084160002
    MCLAUGHLIN, David
    10 Chalfont Crescent
    Wychwood Park Weston
    CW2 5QT Crewe
    Cheshire
    পরিচালক
    10 Chalfont Crescent
    Wychwood Park Weston
    CW2 5QT Crewe
    Cheshire
    British59396160002
    MONBIOT, Raymond Geoffrey
    Eastgate House
    Overy Road
    PE31 8HH Burnham Market
    Norfolk
    পরিচালক
    Eastgate House
    Overy Road
    PE31 8HH Burnham Market
    Norfolk
    EnglandBritish113478330001
    O'CONNELL, Bernard Joseph
    Newstown House
    IRISH Ardattin
    Co Carlow
    Ireland
    পরিচালক
    Newstown House
    IRISH Ardattin
    Co Carlow
    Ireland
    Irish70774570001
    O'SULLIVAN, Kevin Clive
    17 Elgin Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    পরিচালক
    17 Elgin Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    British3562130002
    ODLUM, Philip Edwin
    109 Anglesea Road
    IRISH Ballisbridge
    Dublin 4
    Ireland
    পরিচালক
    109 Anglesea Road
    IRISH Ballisbridge
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish144667960001

    GREENCORE PF LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I Group PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    GREENCORE PF LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৭ এপ্রি, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০২ জানু, ২০২০ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Richard Howard Toone
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London
    অভ্যাসকারী
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    অভ্যাসকারী
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0