PARDEV (LUTON) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPARDEV (LUTON) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02849784
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PARDEV (LUTON) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    PARDEV (LUTON) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PARDEV (LUTON) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ONETRADE LIMITED০১ সেপ, ১৯৯৩০১ সেপ, ১৯৯৩

    PARDEV (LUTON) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৯

    PARDEV (LUTON) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA
    L8HMLVKO

    legacy

    206 পৃষ্ঠাPARENT_ACC
    L8HMLVL0

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2
    L8HMLVKG

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2
    L8HMLVK8

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01
    L8E7WP47

    ১৫ সেপ, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01
    X8EPNZTF

    ১৫ সেপ, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01
    X7FCDFMI

    Benjamin Toby Grose কে পরিচালক হিসাবে অবসানের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    5 পৃষ্ঠাRP04TM01
    L7450CZ6

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA
    L747IDNS

    ১০ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Benjamin Toby Grose এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ১৪ মে, ২০১৮Clarification A second filed TM01 was registered on 14/05/2018
    X73Z50EG

    ১০ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Bruce Michael James-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    X73O1Y4O

    ১৫ সেপ, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01
    X6EZQB55

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA
    L6B0GXR4

    ৩১ অক্টো, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Philip John Martin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01
    X5KWM5Q8

    ৩১ অক্টো, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Philip John Martin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02
    X5KRAXQI

    ৩১ অক্টো, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে British Land Company Secretarial Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04
    X5KRAD7E

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA
    L5JHS31Q

    ০১ সেপ, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01
    X5GYZITT

    ১৩ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Charles John Middleton-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    X5CJBJYX

    ১৩ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Charles Mcnuff-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    X5BNY2GH

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA
    A4IVNPSR

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ সেপ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২২ সেপ, ২০১৫

    ২২ সেপ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01
    X4GG7OKA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA
    A3JGK42O

    PARDEV (LUTON) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর8992198
    187856670001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Secretariat226746900001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    পরিচালক
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    পরিচালক
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Tax Executive79841030002
    MARTIN, Philip John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    সচিব
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    British35118050001
    PEARSON, William
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    সচিব
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    BritishSolicitor206426340001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    পরিচালক
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritishCompany Director40766290003
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    পরিচালক
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    MARTIN, Philip John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant35118050001
    MAXTED, Robert David
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    পরিচালক
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    BritishCompany Director37177990001
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    পরিচালক
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    BritishChartered Accountant109383240001
    MOULD, Harold Raymond
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    পরিচালক
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    EnglandBritishSolicitor35576350006
    PEARSON, William
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    পরিচালক
    12 Hamilton Close
    SE16 1QJ London
    EnglandBritishSolicitor206426340001
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    পরিচালক
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritishChartered Accountant14448630001
    SHEEN, Richard Keith
    53 Elystan Place
    SW3 3JY London
    পরিচালক
    53 Elystan Place
    SW3 3JY London
    BritishCompany Director49750560001
    SMITH, Andrew David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishSurveyor108214880002
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSurveyor106882210001
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    পরিচালক
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director73972350001
    NOROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006410001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001

    PARDEV (LUTON) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Pillar Property Group Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Company Limited By Shares
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।

    PARDEV (LUTON) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge over rent deposit account
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জানু, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and schildvink B.V. (together the borrower) to the chargee and their respective successors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sims from time to time standing to the credit of the borrower in the account number 00214912 in the name of the borrower held with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জানু, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and schildvink B.V.(together the borrower) to the chargee and their respective sucessors and assigns and those deriving title through or under them (together the "lender") or for which the borrower might be or become liable on any account or in any manner
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a units 400,450 and 475 capability green luton t/n BD164321 with all machinery buildings or other erections any sum paid under any insurance policy any deposit paid of any estate or interest in whole or in part of the property & other assets please refer to form 395 for full details and by way of floating charge all undertaking property and assets of the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over acv deposit account
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জানু, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The provisions of clause 12.1.17 of the facility agreement dated 21ST december 1993 made between pillar property PLC,pardev (luton) limited and wurttembergische hypothekenbank ag (as agent and trustee for the lender as defined)and their respective successors and assigns and to those deriving title through or under them (together the "lender") as varied by a first variation agreement dated 10TH june 1994 and as amended and restated by a second variation agreement dated 21ST january 1998 and any subsequent variation and amendment to that agreement provides that it will be an event of default under the facility agreement if certain loan-to-loan requirements are not met unless the company repays part of the loan or provides further security or pays money into the account
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums standing to the credit of the company in an account numbered 00214920 held in the name of the company with the governor and company of the bank of scotland please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wurttembergische Hypothekenbank Ag(As Agent and Trustee for the Lender as Defined)
    • Rheinische Hypothekenbank Ag
    ব্যবসায়
    • ০৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a units 1,100,400,450 and 475 capability green luton t/NOSBD145653,BD132562 and BD164321 and all rents receivable and by way of floating charge all undertaking and property of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over acv deposit account
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of clause 12.1.17 of a facility agreement dated 21ST december 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assignment of all sums from time to time standing to the credit of the company in the acxcount numbered 1528002 at the bank of scotland. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag (As Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over rent deposit
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in a facility agreement dated 21ST december 1993
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assignment by way of security of all sums from time to time standing to the credit of the company in current account number 623461. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wurrtembergische Hypothekenbank Ag
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0