PARKHOUSE PERSONNEL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPARKHOUSE PERSONNEL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02867017
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PARKHOUSE PERSONNEL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অস্থায়ী কর্মসংস্থান সংস্থার কার্যক্রম (78200) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    PARKHOUSE PERSONNEL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1st Floor Randstad Court
    Laporte Way
    LU4 8SB Luton
    Bedfordshire
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PARKHOUSE PERSONNEL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CHARCO 551 LIMITED২৮ অক্টো, ১৯৯৩২৮ অক্টো, ১৯৯৩

    PARKHOUSE PERSONNEL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    PARKHOUSE PERSONNEL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ আগ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ আগ, ২০১২

    ০৭ আগ, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,568,139
    SH01

    ০১ জুল, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Colin Graham Reader এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ১০ জানু, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Reduce share prem a/c to nil 30/12/2011
    RES13

    ১৯ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew John Moss এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Diane Julie Martyn এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ আগ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Andrew John Moss-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ আগ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    23 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা190

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    PARKHOUSE PERSONNEL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WILKINSON, Brian
    The Old Mistal Newsholme
    Oakworth
    BD22 0QT Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    The Old Mistal Newsholme
    Oakworth
    BD22 0QT Keighley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishExecutive Manager11900780002
    KING, James Russell
    15 Penny Croft
    AL5 2PD Harpenden
    Hertfordshire
    সচিব
    15 Penny Croft
    AL5 2PD Harpenden
    Hertfordshire
    British41816520003
    MILES, Charles Kenneth Zachary
    18 Lansdowne Road
    TN1 2NJ Tunbridge Wells
    Kent
    সচিব
    18 Lansdowne Road
    TN1 2NJ Tunbridge Wells
    Kent
    BritishFinance Director39243410001
    ROWLEY, Ann
    Parkhouse 10 Manor Park
    Ruddington
    NG11 6DS Nottingham
    সচিব
    Parkhouse 10 Manor Park
    Ruddington
    NG11 6DS Nottingham
    BritishCompany Secretary37686060001
    HALCO SECRETARIES LIMITED
    8-10 New Fetter Lane
    EC4A 1RS London
    কর্পোরেট সচিব
    8-10 New Fetter Lane
    EC4A 1RS London
    42871950001
    ALLEN, Douglas George
    The Croft Willersley Lane
    Cromford
    DE4 5JG Matlock
    Derbyshire
    পরিচালক
    The Croft Willersley Lane
    Cromford
    DE4 5JG Matlock
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector Of Companies41709610002
    EAGLETON, Antony Sean
    9 Grebe Court
    Wombwell
    S73 0UU Barnsley
    South Yorkshire
    পরিচালক
    9 Grebe Court
    Wombwell
    S73 0UU Barnsley
    South Yorkshire
    BritishChartered Accountant120737950001
    FREE, Malcolm
    Churchside House
    Church Lane
    NG15 8AB Linby
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Churchside House
    Church Lane
    NG15 8AB Linby
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director28515610003
    MARTIN, Anthony Victor
    Aston Court
    Aston Hill
    HP22 5NQ Halton
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Aston Court
    Aston Hill
    HP22 5NQ Halton
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChairman6123340003
    MARTYN, Diane Julie
    Cages Farm
    Tuffields Road, Whepstead
    IP29 4TL Bury St. Edmunds
    Suffolk
    পরিচালক
    Cages Farm
    Tuffields Road, Whepstead
    IP29 4TL Bury St. Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishManaging Director61000610002
    MILES, Charles Kenneth Zachary
    18 Lansdowne Road
    TN1 2NJ Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    18 Lansdowne Road
    TN1 2NJ Tunbridge Wells
    Kent
    BritishFinance Director39243410001
    MOSS, Andrew John
    23 Broughton Road
    Milton Keynes Village
    MK10 9AH Milton Keynes
    The Swan Cottage
    United Kingdom
    পরিচালক
    23 Broughton Road
    Milton Keynes Village
    MK10 9AH Milton Keynes
    The Swan Cottage
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector70841950002
    READER, Colin Graham
    51 Arlington Road
    NW1 7ES London
    পরিচালক
    51 Arlington Road
    NW1 7ES London
    United KingdomBritishDirector3037660001
    ROWLEY, Ann
    Parkhouse 10 Manor Park
    Ruddington
    NG11 6DS Nottingham
    পরিচালক
    Parkhouse 10 Manor Park
    Ruddington
    NG11 6DS Nottingham
    BritishCompany Secretary37686060001
    ROWLEY, John
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    পরিচালক
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    EnglandBritishCompany Director11900790002
    SIMMONDS, John
    2 Elm Grange
    Cow Lane
    SK9 2AZ Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    2 Elm Grange
    Cow Lane
    SK9 2AZ Wilmslow
    Cheshire
    BritishRecruitment85472030001
    HALCO MANAGEMENT LIMITED
    8-10 New Fetter Lane
    EC4A 1RS London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    8-10 New Fetter Lane
    EC4A 1RS London
    900005590001
    RECRUITMENT FINANCE LIMITED
    Hale Court
    Lincolns Inn
    WC2A 3UL London
    কর্পোরেট পরিচালক
    Hale Court
    Lincolns Inn
    WC2A 3UL London
    37818030001

    PARKHOUSE PERSONNEL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The balance from time to time standing to the credit of the deposit account being a separate interest-bearing deposit account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mh (Holtender) Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Company's interest in the seperate designated interest-bearing deposit account to be opened by the mortgagee. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • William Davis Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 23 may 1994 and/or this debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Recruitment Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Tsb Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0