BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02873670
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • পারফিউম এবং টয়লেট প্রস্তুতি উৎপাদন (20420) / উৎপাদন

    BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    New Kings Court Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    Hampshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HAMPSHIRE COSMETICS LIMITED২৭ অক্টো, ১৯৯৪২৭ অক্টো, ১৯৯৪
    RIDGEROW LIMITED১৯ নভে, ১৯৯৩১৯ নভে, ১৯৯৩

    BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৮

    BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    ১৯ নভে, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ২৬ সেপ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Wystan Corporate Services Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ সেপ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Wystan Holdings Inc এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    49 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Decisions and resolutions ratified and approved 22/08/2018
    RES13
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    ২২ আগ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Wystan Holdings Inc-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ১৯ নভে, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ১৯ নভে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ নভে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ নভে, ২০১৫

    ২০ নভে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,650,200
    SH01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    AA

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ নভে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ ডিসে, ২০১৪

    ০৫ ডিসে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,650,200
    SH01

    কোম্পানি বাদ দেওয়ার আবেদন প্রত্যাহার করুন

    1 পৃষ্ঠাDS02

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    ১৫ জানু, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 200
    4 পৃষ্ঠাSH19

    BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর1914417
    38915800008
    SMITH, Adrian Holmes
    St Ives Park
    BN24 2JX Ringwood
    57
    Hampshire
    পরিচালক
    St Ives Park
    BN24 2JX Ringwood
    57
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Accountant51302090001
    BLAND, Michael James
    Apartado 3531
    8135 Almancil
    Portugal
    সচিব
    Apartado 3531
    8135 Almancil
    Portugal
    British94686660002
    SANDERS, Robert Braith Charles
    Waterberry Drive
    PO7 7YW Waterlooville
    Brambles House
    Hampshire
    United Kingdom
    সচিব
    Waterberry Drive
    PO7 7YW Waterlooville
    Brambles House
    Hampshire
    United Kingdom
    149449750001
    YOUNGER, Marilyn Claire
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    সচিব
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    BritishCompany Secretary38965710001
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর1914417
    38915800008
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    900001990001
    DARKE, Charles Peter
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    পরিচালক
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishDirector61772430003
    HARDY, Audrey Sylvia
    4201 Kean Road
    33314 Port Lauderdale
    Florida
    পরিচালক
    4201 Kean Road
    33314 Port Lauderdale
    Florida
    BritishDirector39006670002
    HAYWOOD, Julia Louise
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    পরিচালক
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishDirector160954760001
    JORDAN, Nicola
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    পরিচালক
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector160951730001
    POLDING, Mark
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    পরিচালক
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector160951850001
    SANDERS, Robert Braith Charles
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    পরিচালক
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector70944840001
    SPERRING, Mark Anthony
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    পরিচালক
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector160951960001
    VINE, David Graham
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    পরিচালক
    Brambles House
    Waterberry Drive
    PO7 7UW Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector160952040001
    WAITE, Thomas Edward
    4201 Kean Road
    33314 Fort Lauderdale
    Florida
    Usa
    পরিচালক
    4201 Kean Road
    33314 Fort Lauderdale
    Florida
    Usa
    BritishDirector39006760002
    YOUNGER, Marilyn Claire
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    পরিচালক
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    BritishCompany Secretary38965710001
    YOUNGER, Marilyn Claire
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    পরিচালক
    The Grange
    Church Road New Town
    PO17 6LE Fareham
    Hampshire
    BritishDirector38965710001
    YOUNGER, Paul Owen
    Church Road
    Newtown
    PO17 6LA Fareham
    The Grange
    Hampshire
    পরিচালক
    Church Road
    Newtown
    PO17 6LA Fareham
    The Grange
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director6788640001
    ALDEBURGH ENTERPRISES LIMITED
    Suite 2a Eurolife Building
    1 Corral Road
    FOREIGN Gibraltar
    কর্পোরেট পরিচালক
    Suite 2a Eurolife Building
    1 Corral Road
    FOREIGN Gibraltar
    46113110001
    BLAKELAW DIRECTOR SERVICES LIMITED
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    900001980001
    C L CLEMO & CO CORPORATE SERVICES LIMITED
    88 Copse Hill
    Wimbledon Common
    SW20 0EF London
    কর্পোরেট পরিচালক
    88 Copse Hill
    Wimbledon Common
    SW20 0EF London
    42479600001
    NEW CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    P.O. Box 146 Roadtown
    Tortola
    FOREIGN British Virgin Islands
    কর্পোরেট পরিচালক
    P.O. Box 146 Roadtown
    Tortola
    FOREIGN British Virgin Islands
    48067050001
    WYSTAN CORPORATE SERVICES LIMITED
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Turks And Caicos Islands
    কর্পোরেট পরিচালক
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Turks And Caicos Islands
    আইনি ফর্মEXEMPTED COMPANY
    পরিচয়পত্রের ধরননন ইইএ
    আইনি কর্তৃপক্ষTHE COMPANIES ORDANCE 1981
    নিবন্ধন নম্বরE39405
    174566920001
    WYSTAN CORPORATE SERVICES LIMITED
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Bwi
    Turks & Caicos Islan
    কর্পোরেট পরিচালক
    Leeward Highway
    Providenciales
    Bcm Buildings
    Bwi
    Turks & Caicos Islan
    আইনি ফর্মEXEMPTED COMPANY
    পরিচয়পত্রের ধরননন ইইএ
    আইনি কর্তৃপক্ষTHE COMPANIES ORDINANCE 1981
    নিবন্ধন নম্বরE.39405
    145995950001
    WYSTAN HOLDINGS INC
    Leeward Highway
    Providenciales
    PO BOX 267, Bcm Cape Building
    Turks And Caicos Islands
    কর্পোরেট পরিচালক
    Leeward Highway
    Providenciales
    PO BOX 267, Bcm Cape Building
    Turks And Caicos Islands
    আইনি ফর্মCORPORATE
    পরিচয়পত্রের ধরননন ইইএ
    আইনি কর্তৃপক্ষTURKS AND CAICOS ISLANDS
    নিবন্ধন নম্বর29228
    249686940001

    BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England And Wales)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর06237275
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    BRAMBLES HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Asset name vibratory bowl feeder (model avb 460F) serial number AS496. Sleevit sleevemaster serial number SM850. Beltorgue cup tighting machine mode bt-st serial J10-015.00.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD and Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুল, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুল, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুল, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুন, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুন, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    All assets debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ নভে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Venture Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ নভে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a loan agreement of even date or the mortgage debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a brambles house, waterberry drive, waterlooville hampshire t/no: HP414945 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hampshire Cosmetic Laboratories Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/as brambles house waterberry drive waterlooville hampshire.t/no.HP414945 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0