NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামNATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02899075
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Unit D Fleming Centre
    Fleming Way
    RH10 9NN Crawley
    West Sussex
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SPARKLING SPRING WATER UK LIMITED১০ মে, ১৯৯৪১০ মে, ১৯৯৪
    WITHTRADE LIMITED১৬ ফেব, ১৯৯৪১৬ ফেব, ১৯৯৪

    NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০৫ ফেব, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Yariv Shapira এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৫ ফেব, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Olivier Plouvin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৮ ফেব, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 201 Bedford Avenue Slough Berkshire SL1 4RY থেকে Unit D Fleming Centre Fleming Way Crawley West Sussex RH10 9NNপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ০৫ ফেব, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Brian Richard Macpherson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ মে, ২০১৫

    ১৩ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 14.73
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ মে, ২০১৪

    ১৪ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 14.73
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Maclay Murray & Spens Llp-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    সচিব হিসাবে Sf Secretaries Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ১৭ জানু, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.47
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share prem a/c reduced to nil 23/12/2010
    RES13

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    কর্পোরেট সচিব
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বরSO300744
    119967690001
    MACPHERSON, Brian Richard
    Fleming Centre
    Fleming Way
    RH10 9NN Crawley
    Unit D
    West Sussex
    England
    পরিচালক
    Fleming Centre
    Fleming Way
    RH10 9NN Crawley
    Unit D
    West Sussex
    England
    ScotlandBritish205282630001
    HARVEY, Kristine
    2 Kinneil House
    The Furlongs
    ML3 0DX Hamilton
    South Lanarkshire
    সচিব
    2 Kinneil House
    The Furlongs
    ML3 0DX Hamilton
    South Lanarkshire
    British90110940001
    HURLEY, Caroline Margaret Mary
    1 Temple Fortune Lane
    NW11 7UB London
    সচিব
    1 Temple Fortune Lane
    NW11 7UB London
    British35118780002
    STORDY, Lawrence John
    1959 Woodlawn Terrace
    Halifax
    Nova Scotia B3h 4g5
    Canada
    সচিব
    1959 Woodlawn Terrace
    Halifax
    Nova Scotia B3h 4g5
    Canada
    Canadian55997150001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    কর্পোরেট সচিব
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    SF SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    123
    United Kingdom
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    St. Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    123
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বরSC128549
    900029010002
    ALLEN, Stewart Ernest
    Flat 5 1 Saint Swithins Street
    WR1 2PY Worcester
    Worcestershire
    পরিচালক
    Flat 5 1 Saint Swithins Street
    WR1 2PY Worcester
    Worcestershire
    Canadian57767250005
    BRINDLEY, Philippa Lucy
    Chemin Aime Steinlen 10
    FOREIGN Lausanne
    1004
    Switzerland
    পরিচালক
    Chemin Aime Steinlen 10
    FOREIGN Lausanne
    1004
    Switzerland
    British121958280001
    CUNIA, Gadi
    Rte Des Monts-De-Lavaux 496
    La Croix-Sur-Lutry
    Ch-1090
    Switzerland
    পরিচালক
    Rte Des Monts-De-Lavaux 496
    La Croix-Sur-Lutry
    Ch-1090
    Switzerland
    Israeli95798400001
    GOODICK, Arthur
    29 Fieldwood Circle
    Dartmouth Ns
    FOREIGN Nova Scotia B2w 4s5
    Canada
    পরিচালক
    29 Fieldwood Circle
    Dartmouth Ns
    FOREIGN Nova Scotia B2w 4s5
    Canada
    Canadian46409180001
    GUTTINGER, Antoine Jean Yves
    Rue De Zurich,42
    FOREIGN Ch-1201, Geneva
    Switzerland
    পরিচালক
    Rue De Zurich,42
    FOREIGN Ch-1201, Geneva
    Switzerland
    French91634680002
    HECKER, Michael
    Ch. De La Bernadez, Ch-1094
    FOREIGN Paudex
    Switzerland
    পরিচালক
    Ch. De La Bernadez, Ch-1094
    FOREIGN Paudex
    Switzerland
    Swiss95785580001
    HOWIE, William
    22 East Heath Road
    Hampstead
    NW3 1AH London
    9 Ladywell Court
    পরিচালক
    22 East Heath Road
    Hampstead
    NW3 1AH London
    9 Ladywell Court
    United KingdomBritish131129520001
    HURLEY, Caroline Margaret Mary
    1 Temple Fortune Lane
    NW11 7UB London
    পরিচালক
    1 Temple Fortune Lane
    NW11 7UB London
    United KingdomBritish35118780002
    KITLEY, Robert
    Old Legion Hall
    Hodnet
    TFN 3NP Market Drayton
    Shropshire
    পরিচালক
    Old Legion Hall
    Hodnet
    TFN 3NP Market Drayton
    Shropshire
    British120884570001
    KITLEY, Robert Gowan
    113 Abbey Foregate
    SY2 6BA Shrewsbury
    Shropshire
    পরিচালক
    113 Abbey Foregate
    SY2 6BA Shrewsbury
    Shropshire
    British74088350003
    KREDIET, Gerrit Johan
    14 Royal Court House
    162 Sloane Street
    SW1X 9BS London
    পরিচালক
    14 Royal Court House
    162 Sloane Street
    SW1X 9BS London
    Dutch58139850001
    LARSON, Stephen Lawrence
    38 Briar Brae Road
    Darrien
    Connecticut
    Usa 06820
    পরিচালক
    38 Briar Brae Road
    Darrien
    Connecticut
    Usa 06820
    American53746080001
    O'HARA, Kerry Ann
    16 Kingslawn Close
    SW15 6QJ London
    পরিচালক
    16 Kingslawn Close
    SW15 6QJ London
    British62584140001
    PLOUVIN, Olivier
    59 Rue Du General Leclerc
    Audresy
    78570
    France
    পরিচালক
    59 Rue Du General Leclerc
    Audresy
    78570
    France
    FranceFrench124866330001
    SCHICKLI, Dillon
    8951 Bald Eagle Drive
    Blaine
    Wa 98230
    Usa
    পরিচালক
    8951 Bald Eagle Drive
    Blaine
    Wa 98230
    Usa
    American58715400004
    SHAPIRA, Yariv
    Hod-Hasharon
    Zamir 39
    45350
    Israel
    পরিচালক
    Hod-Hasharon
    Zamir 39
    45350
    Israel
    IsraelIsraeli136488220001
    SHAPIRA, Yariv
    Hod-Hasharon
    Zamir 39
    45350
    Israel
    পরিচালক
    Hod-Hasharon
    Zamir 39
    45350
    Israel
    IsraelIsraeli136488220001
    STEPHENS, Richard Wayne
    9 Bury Farm
    HP7 0SJ Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    9 Bury Farm
    HP7 0SJ Amersham
    Buckinghamshire
    Canadian88863720001
    NOROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006410001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001

    NATURE SPRINGS WATER COMPANY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee and the banks (as defined) or any of them under or pursuant to the credit agreement and or the guarantee and debenture and/or any ancillary documents contemplated by the credit agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Toronto-Dominion Bank(As Security Agent for the Banks)
    ব্যবসায়
    • ১৫ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ নভে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) under or in connection with any of the financing documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ নভে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rental deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease dated 28TH june 1996
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies deposited from time to time in the deposit account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Moatstar Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank of Canada
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    An assignment of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with any of the financing documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys thereby assured which may become payable thereunder and the full benefit thereof as a continuing security to the bank for the discharge on demand of the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of rental deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জুল, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুল, ১৯৯৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit account (and all monies therein and from time to time withdrawn therefrom) maintained in the nam of russell-cooke potter & chapman at national westminster bank PLC 153 putney high street london SW15.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Moatstar Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুন, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুন, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0