PECASO UK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPECASO UK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02901590
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PECASO UK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7260) /

    PECASO UK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PECASO UK LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ACCESS CONSULTING LIMITED২৩ ফেব, ১৯৯৪২৩ ফেব, ১৯৯৪

    PECASO UK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ আগ, ২০০৯

    PECASO UK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.71

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    3 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৬ এপ্রি, ২০১০ তারিখে

    LRESSP

    পূর্ণ হিসাব ৩১ আগ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    ৩১ ডিসে, ২০০৯ তারিখে David Charles Thomlinson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Patrick Brian Francis Rowe-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Patrick Brian Francis Rowe-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ২৪ নভে, ২০০৯ তারিখে শেয়ার একত্রীকরণ

    5 পৃষ্ঠাSH02

    ২৪ নভে, ২০০৯ তারিখে শেয়ার একত্রীকরণ

    5 পৃষ্ঠাSH02

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    27 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    শেয়ারের অধিকার বা নাম পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES12
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    পরিচালক হিসাবে Mr Anthony Gerard Coughlan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Timothy Robinson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    PECASO UK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ROWE, Patrick Brian Francis
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    সচিব
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    British140245520001
    COUGHLAN, Anthony Gerard
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    পরিচালক
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    United KingdomIrish And AmericanPrincipal Accounting Officer146489390001
    ROWE, Patrick Brian Francis
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    পরিচালক
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    EnglandBritishSolicitor140245520001
    THOMLINSON, David Charles
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    পরিচালক
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    United KingdomBritishManagement Consultant115623850001
    DONAGHY, Lawrence
    162 Tilehouse Lane
    Tidbury Green
    B90 1PW Shirley
    Solihull
    সচিব
    162 Tilehouse Lane
    Tidbury Green
    B90 1PW Shirley
    Solihull
    British85298010002
    MARSON, Lorraine Jean
    8 Greville Road
    B49 5QN Alcester
    Warwickshire
    সচিব
    8 Greville Road
    B49 5QN Alcester
    Warwickshire
    BritishCompany Secretary38163870001
    MARSON, Paul Graham
    3 The Dell Rookery Lane
    Ettington
    CV37 7TQ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    সচিব
    3 The Dell Rookery Lane
    Ettington
    CV37 7TQ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British38163920008
    WALKER, Stephen Adrian
    198 Courthouse Road
    SL6 6HU Maidenhead
    Berkshire
    সচিব
    198 Courthouse Road
    SL6 6HU Maidenhead
    Berkshire
    British13466600001
    WHITAKER, Anne Michelle
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    সচিব
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector38436390001
    BRADLEY, Timothy Jonathan Sean
    Springfield House
    Nottingham Road
    NG25 0QW Southwell
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Springfield House
    Nottingham Road
    NG25 0QW Southwell
    Nottinghamshire
    BritishSales Director63096120002
    CHEESE, Peter Ayrton
    Bachelors Farm
    Long Reach
    GU23 6PG Ockham
    Surrey
    পরিচালক
    Bachelors Farm
    Long Reach
    GU23 6PG Ockham
    Surrey
    EnglandBritishManagement Consultant142344420001
    COOK, Richard
    10 Chudleigh Road
    HG1 5NP Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    10 Chudleigh Road
    HG1 5NP Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector104633580001
    DEAN, Michael Paul
    38 Hawthorn Road
    WR11 6HP Evesham
    Worcestershire
    পরিচালক
    38 Hawthorn Road
    WR11 6HP Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritishOperations Director67846460001
    FRANKENFELD, Siegmund Peter
    6 Hoogenhout Crescent Lowehill
    South Africa Box 906
    FOREIGN Lonehill 2062
    পরিচালক
    6 Hoogenhout Crescent Lowehill
    South Africa Box 906
    FOREIGN Lonehill 2062
    South AfricanBusinessman63906080001
    HARLOW, Gary David
    5 Woolston Road
    Gauteng
    Westcliff
    2193
    South Africa
    পরিচালক
    5 Woolston Road
    Gauteng
    Westcliff
    2193
    South Africa
    South AfricanChartered Accountant66165990001
    HEAD, Michael Richard
    Derwent Alma Road
    Headley Down
    GU35 8JR Bordon
    Hampshire
    পরিচালক
    Derwent Alma Road
    Headley Down
    GU35 8JR Bordon
    Hampshire
    BritishDirector62324230001
    HEAD, Michael Richard
    Derwent Alma Road
    Headley Down
    GU35 8JR Bordon
    Hampshire
    পরিচালক
    Derwent Alma Road
    Headley Down
    GU35 8JR Bordon
    Hampshire
    BritishI.T. Consultant62324230001
    HILL, Mary Elizabeth
    Walnut Tree House
    Goose Walk
    OX15 4JD Bloxham Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Walnut Tree House
    Goose Walk
    OX15 4JD Bloxham Banbury
    Oxfordshire
    BritishCustomer Services Manager77072380001
    LOAKES, Robert Thomas
    Chase Cottage
    Charingworth Chase
    GL55 6NU Charingworth
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Chase Cottage
    Charingworth Chase
    GL55 6NU Charingworth
    Gloucestershire
    BritishSoftware Consultant68056610002
    MARSON, Paul Graham
    3 The Dell Rookery Lane
    Ettington
    CV37 7TQ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    3 The Dell Rookery Lane
    Ettington
    CV37 7TQ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishComputer Software Consultant38163920008
    O'SULLIVAN, Matthew
    7 Queens Crescent
    TW10 6HG Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    7 Queens Crescent
    TW10 6HG Richmond
    Surrey
    EnglandBritishAccountant46307060002
    ROBINSON, Timothy James
    Gibson Square
    N1 0RA London
    59
    United Kingdom
    পরিচালক
    Gibson Square
    N1 0RA London
    59
    United Kingdom
    BritishDirector53265180003
    SMITH, Richard
    Liberton House
    2 Walton Close Whissendene
    LE15 7FB Oakham
    Rutland Leicestershire
    পরিচালক
    Liberton House
    2 Walton Close Whissendene
    LE15 7FB Oakham
    Rutland Leicestershire
    BritishSoftware Consultant87993510001
    STRICKLAND, Malcolm Stuart
    Walnut Tree
    Goose Walk Blox
    OX15 4JD Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Walnut Tree
    Goose Walk Blox
    OX15 4JD Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector104633650001
    WALKER, Stephen Adrian
    198 Courthouse Road
    SL6 6HU Maidenhead
    Berkshire
    পরিচালক
    198 Courthouse Road
    SL6 6HU Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Secretary13466600001
    WHITAKER, Anne Michelle
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector38436390001
    WHITAKER, Robert Alston
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishDirector37434920001

    PECASO UK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Isis Equity Partners Limited (The Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২১ মে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    PECASO UK LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৬ এপ্রি, ২০১০ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ৩০ নভে, ২০১০ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Peter James Hughes-Holland
    Rsm Tenon Restructuring
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    অভ্যাসকারী
    Rsm Tenon Restructuring
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Francis F A Wessely
    Rsm Tenon Restructuring
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    অভ্যাসকারী
    Rsm Tenon Restructuring
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0