KENTCO LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামKENTCO LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিলিকুইডেশন
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02925662
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    KENTCO LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /

    KENTCO LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Enterprise House
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    KENTCO LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    LOMBARD STREET PROPERTIES (CANTERBURY) LIMITED২৭ ডিসে, ১৯৯৬২৭ ডিসে, ১৯৯৬
    LOMBARD STREET PROPERTIES (IPSWICH) LIMITED২৭ নভে, ১৯৯৫২৭ নভে, ১৯৯৫
    LOMBARD STREET PROPERTIES (ASHFORD) LIMITED২১ জুল, ১৯৯৪২১ জুল, ১৯৯৪
    BROOMCO (779) LIMITED০৪ মে, ১৯৯৪০৪ মে, ১৯৯৪

    KENTCO LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ আগ, ২০১০
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ মে, ২০১১
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ আগ, ২০০৯

    KENTCO LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৪ মে, ২০১৭
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৮ মে, ২০১৭
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    KENTCO LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    KENTCO LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    রিসিভার বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ

    4 পৃষ্ঠাRM02

    ০১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Stuart Roy Dixon এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ০৬ ফেব, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Longworth Birchenall এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ০৭ মে, ২০১৬ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৭ নভে, ২০১৫ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৭ মে, ২০১৫ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৭ নভে, ২০১৪ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    রিসিভার বা ম্যানেজারের নিযুক্তি

    10 পৃষ্ঠাRM01

    রিসিভার বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ

    1 পৃষ্ঠাRM02

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    পরিচালক হিসাবে Christopher Hancock এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    12 পৃষ্ঠা4.72

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    5 পৃষ্ঠা4.20

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন

    LRESEX

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাLQ01

    সচিব হিসাবে Mr Stuart Roy Dixon-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ মে, ২০১১

    ০৫ মে, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    পরিচালক হিসাবে Mr Christopher Hancock-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Stuart Dixon এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    KENTCO LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    DIXON, Stuart Roy
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    সচিব
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    159847750001
    FAULKNER, Robert Michael Stanley
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    সচিব
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    BritishProject Manager27616940001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    BIRCH, Sally Ann
    150 Wilden Lane
    DY13 9LP Stourport On Severn
    Worcestershire
    পরিচালক
    150 Wilden Lane
    DY13 9LP Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritishSecretary123289480001
    BIRCHENALL, David Longworth
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    পরিচালক
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    United KingdomBritishDirector118115050001
    DIXON, Stuart Roy
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House, Stag Place
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House, Stag Place
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant56735900001
    FAULKNER, Robert Michael Stanley
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    পরিচালক
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    EnglandBritishProject Manager27616940001
    HANCOCK, Christopher
    Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Kynnersley
    England
    পরিচালক
    Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Kynnersley
    England
    EnglandBritishSurveyor87069290001
    LAWRENCE, Angela Rosemary
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    পরিচালক
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    BritishPrivate Secretary27616950001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    KENTCO LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any group member to the chargee or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 49/51 gallowtree gate leicester t/no LT42533 and LT2133 and f/h property k/a 29 gallowtree gate and 65/69 market place and 1 3 and 5 victoria parade t/no's LT297194 LT13323 LT34591 and LT18286. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    ব্যবসায়
    • ০৮ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • 3০৪ ডিসে, ২০১৩একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (RM01)
    • 3১১ জুল, ২০১৭একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (RM02)
      • মামলা নম্বর 3
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any group member to the chargee or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest under the leases in respect of f/h property k/a 49/51 gallowtree gate leicester t/no LT42533 and LT2133 and f/h property k/a 29 gallowtree gate and 65/69 market place and 1 3 and 5 victoria parade t/no's LT297194 LT13323 LT34591 and LT18286. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • 1০৬ জুল, ২০১১একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (LQ01)
    • 1২৩ নভে, ২০১৩একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (RM02)
      • মামলা নম্বর 1
    Second legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,520,000 and all other monies due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    49/51 gallowtree gate leicester t/no LT42533 and LT2133 65 67 69 market place 29 gallowtree gate and 1 3 and 5 victoria parade leicester t/no's LT18286 LT13323 LT34591 and LT297194.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dawnay Day Property Equity Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ ফেব, ২০০৮
    • ২৪ ডিসে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture (floating charge)
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A first floating charge all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nationwide Building Society
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold land k/a 28 high street canterbury kent t/n K797851 and freehold landbeing 28 and 29 high street canterbury K. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nationwide Building Society
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of yearly rents
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Any and all sums due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document (as defined) to the chargee under the terms of an agreement constituted by a facility letter dated 13 october 1997 the assignment or any other related security document (as defined) or on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company's right,title and interest in and to the clear yearly rents reserved or to be reserved by the existing leases of the land and premises k/a 28/29 high street and 2/5 stour street canterbury kent and any leases of such land and premises or any part thereof subsequently granted within 21 years of the assignment.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over construction contract
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Any and all sums due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document (as defined) to the chargee under the terms of a facility agreement dated 13 october 1997 this deed or any related security document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    "The contract" shall herein mean a construction contract dated 12 december 1997 for the development of 28/29 high street canterbury kent together with any bond issued pursuant thereto.the company's present and future rights,title and interest in and to the contract.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    General security assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    "The contract" shall herein mean an agreement for the grant of a lease of the ground and first floor premises at 29 high street canterbury kent.the benefit of the company's right,title and interest in and to the contract.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of set off
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The monies now or hereafter to be standing to the credit of any account of the company at the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h property k/a 29 high street canterbury kent.t/no.K287165.. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £250,000 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The land to be comprised in the title number referred to in the charge including the buildings on the land k/a 28 high street and 2-5 stour street canterbury kent. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • James Bruce Lee Palmer
    ব্যবসায়
    • ১২ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of yearly rents
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document (as defined) to the chargee under or pursuant to the terms of an agreement constituted by a facility letter dated 12TH february 1997, the assignment or any other related security document (as defined) or on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The companys right title and interest in and to the clear yearly rents reserved or to be reserved by the existing leases of the land and premises situate and k/a 28 high street and 2-5 stour street canterbury kent. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h property and the buildings thereon k/a 28 high street and 2-5 stour street canterbury kent and all those buildings at first floor level and above adjoining the property first referred to but excluding the ground or roadway and those buildings at first floor level including all fixtures fittings fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Equitable mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £125,000.00 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The contract dated 17/2/97 and any deeds and documents for the purchase of further interests in 28 high street, canterbury, kent and the full benefit thereof and the equitable interest of the company in the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • James Bruce Lee Palmer
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    KENTCO LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1রিসিভার/ম্যানেজার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    J Green
    Elliott House 28a Devonshire Street
    W1G 6PS London
    রিসিভার ম্যানেজার
    Elliott House 28a Devonshire Street
    W1G 6PS London
    2
    তারিখপ্রকার
    ০৫ জুল, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Robin Hamilton Davis
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    অভ্যাসকারী
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    Melvyn Julian Carter
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    অভ্যাসকারী
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    3রিসিভার/ম্যানেজার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Jemma Kathleen Mcandrew
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    রিসিভার ম্যানেজার
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Richard James Stanley
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    রিসিভার ম্যানেজার
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0