EASYNET LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামEASYNET LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিরূপান্তরিত / বন্ধ
    আইনি ফর্মরূপান্তরিত / বন্ধ
    কোম্পানি নম্বর 02954343
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    EASYNET LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য টেলিকমিউনিকেশন কার্যক্রম (61900) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    EASYNET LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o INTEROUTE COMMUNICATIONS LIMITED
    31st Floor 25 Canada Square
    E14 5LQ London
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    EASYNET LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০১৭
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ সেপ, ২০১৮
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৬

    EASYNET LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ফ্রেন্ডলি সোসাইটির নিবন্ধন শংসাপত্র

    পৃষ্ঠাCERTIPS

    বিবিধ

    Confirmation of transfer of assets and liabilities
    1 পৃষ্ঠাMISC

    বিবিধ

    Copy of order for completion of merger
    2 পৃষ্ঠাMISC

    বিবিধ

    CB01 - notice of a cross border merger
    99 পৃষ্ঠাMISC

    ১৭ জুল, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    চার্জ 029543430013 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 029543430015 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 029543430014 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ৩১ মে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Christopher Turing Mckee-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ মে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael Thomas Sicoli-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ মে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jessica Anne Kaman-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ মে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Catherine Birkett এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ মে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gareth John Williams এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বিবিধ

    CB01 draft terms of merger
    78 পৃষ্ঠাMISC

    ১৩ ডিসে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Yasmin Jaffer এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ নিবন্ধন 029543430015, ০৯ অক্টো, ২০১৭ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    37 পৃষ্ঠাMR01

    ১৩ অক্টো, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Philip Howard Grannum এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০২ অক্টো, ২০১৭ তারিখে Mrs Catherine Birkett-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০২ অক্টো, ২০১৭ তারিখে Mrs Catherine Birkett-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৭ জুল, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    30 পৃষ্ঠাAA

    ১৫ নভে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Philip Howard Grannum-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৫ নভে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Allan Shearing এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ নিবন্ধন 029543430014, ১৪ নভে, ২০১৬ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    41 পৃষ্ঠাMR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    38 পৃষ্ঠাAA

    EASYNET LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    KAMAN, Jessica Anne
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    পরিচালক
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    United StatesAmericanVice President Of Finance And Treasurer247161660001
    MCKEE, Christopher Turing
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    পরিচালক
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    United StatesAmericanGeneral Counsel161500200001
    SICOLI, Michael Thomas
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    পরিচালক
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    United StatesAmericanManaging Director246929820001
    CROFT, Richard James
    3 Westbourne Road
    Sydenham
    SE26 5NJ London
    সচিব
    3 Westbourne Road
    Sydenham
    SE26 5NJ London
    BritishCompany Secretary81319370001
    HART, Terence Alan
    71 Faraday Road
    SW19 8PE London
    সচিব
    71 Faraday Road
    SW19 8PE London
    BritishAccountant71912960002
    MCDOWELL, Shaun
    20 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    সচিব
    20 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    British29485990002
    ROWE, David Stanley
    43 Wells Street
    W1T 3PW London
    সচিব
    43 Wells Street
    W1T 3PW London
    BritishCompany Director70181650002
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003220001
    BIRKETT, Catherine
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    পরিচালক
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer201977420002
    CHURCHILL, Wayne Winston
    Oldbury
    RG12 8TH Bracknell
    St James House
    Berkshire
    England
    পরিচালক
    Oldbury
    RG12 8TH Bracknell
    St James House
    Berkshire
    England
    EnglandSouth AfricanCompany Director155037400001
    CLARKE, Greg
    5 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Chancellor House
    United Kingdom
    পরিচালক
    5 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Chancellor House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector170612590001
    CROFT, Richard James
    3 Westbourne Road
    Sydenham
    SE26 5NJ London
    পরিচালক
    3 Westbourne Road
    Sydenham
    SE26 5NJ London
    EnglandBritishCompany Secretary81319370001
    DAVIES, Graham Brian
    8a Willenhall Avenue
    EN5 1JN Barnet
    Hertfordshire
    পরিচালক
    8a Willenhall Avenue
    EN5 1JN Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director79457480001
    FENTON, Geoffrey Eric Crosland, Reverend
    Grove Cottage
    Redmans Hill, Blackford
    BS28 4NG Wedmore
    Somerset
    পরিচালক
    Grove Cottage
    Redmans Hill, Blackford
    BS28 4NG Wedmore
    Somerset
    EnglandBritishCompany Director83173480001
    GARDINER, Dwight Daniel Willard
    SW5
    পরিচালক
    SW5
    United KingdomBritish,AmericanChief Financial Officer76076980002
    GRANNUM, Philip Howard
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    পরিচালক
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    EnglandBritishEvp, Uk Sales155095270001
    HART, Terence Alan
    71 Faraday Road
    SW19 8PE London
    পরিচালক
    71 Faraday Road
    SW19 8PE London
    BritishAccountant71912960002
    HICKS, David Marvin
    26 Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    Middlesex
    পরিচালক
    26 Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritishDirector107950240001
    HILL, Peter Arthur
    78 Sheephouse Road
    SL6 8HP Maidenhead
    Berkshire
    পরিচালক
    78 Sheephouse Road
    SL6 8HP Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector37071270001
    JAFFER, Yasmin
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    পরিচালক
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    BulgariaBritishBusiness Executive202048620001
    MULFORD, Michael Timothy
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    পরিচালক
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    EnglandBritishCompany Director20912630005
    MULLAN, Philip Roy
    1 Wellington Mansions
    Shacklewell Road
    N16 7TP London
    পরিচালক
    1 Wellington Mansions
    Shacklewell Road
    N16 7TP London
    BritishCompany Director7779340001
    MULLIGAN, Brian Kenneth
    46 Penwood Heights
    Burghclere
    RG15 9EZ Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    46 Penwood Heights
    Burghclere
    RG15 9EZ Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director7040040001
    PALMER, Bradley Regan Leonard
    5 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Chancellor House
    United Kingdom
    পরিচালক
    5 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Chancellor House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer124281070001
    PROTHEROE, John Robert Clement
    51 Beaufort Mansions
    Chelsea
    SW3 5AF London
    পরিচালক
    51 Beaufort Mansions
    Chelsea
    SW3 5AF London
    BritishChartered Accountant110219540001
    RAFFERTY, Neil Martin
    Rue Du Vallon 1
    Ohain
    B-1380
    Belgium
    পরিচালক
    Rue Du Vallon 1
    Ohain
    B-1380
    Belgium
    BelgiumBritishCompany Director80196600001
    ROWE, David Stanley
    42 Arkwright Road
    NW3 6BH London
    পরিচালক
    42 Arkwright Road
    NW3 6BH London
    EnglandBritishCompany Director70181650003
    SHEARING, John Allan
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    পরিচালক
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    BelgiumBritishBusiness Executive191514220001
    TEARE, Keith William
    35 Corto Lane
    Woodside
    California Ca 94062
    Usa
    পরিচালক
    35 Corto Lane
    Woodside
    California Ca 94062
    Usa
    BritishComputer Consultant74798030001
    THOMPSON, Mark James
    Oldbury
    RG12 8TH Bracknell
    St James House
    Berkshire
    England
    পরিচালক
    Oldbury
    RG12 8TH Bracknell
    St James House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director136456200001
    WILLIAMS, Gareth John
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    পরিচালক
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    United KingdomBritishChief Executive Officer126668950001
    YOUNG, Keith
    14 Godfrey Street
    SW3 3TA London
    পরিচালক
    14 Godfrey Street
    SW3 3TA London
    BritishCompany Director19203550003
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    EASYNET LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Mdnx Group Holdings Ltd
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    C/O Interoute Communications Ltd, 31st Floor
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    C/O Interoute Communications Ltd, 31st Floor
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশUk
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানUk Companies Registry
    নিবন্ধন নম্বর08708409
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    EASYNET LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ২০১৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ২০১৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Not applicable.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ অক্টো, ২০১৭একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০৮ জুন, ২০১৮একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০১৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০৮ জুন, ২০১৮একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জানু, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জানু, ২০১৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ জানু, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০৮ জুন, ২০১৮একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জানু, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জানু, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Highbridge Principal Strategies, Llc
    ব্যবসায়
    • ১৪ জানু, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০৫ নভে, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ নভে, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings plant and machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (in Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ১৫ নভে, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৫ আগ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture (all liabilities)
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any member of the group, the parent and by each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Trustee for the Secured Parties (the Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৮ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৫ আগ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any member of the group the parent and by each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Trustee for the Secured Parties (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৮ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৫ আগ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of accession and charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    With full title guarantee the benefit of all acquisition claims and all tight title and interest from time to time in any sums payable in pursuant of insurance policies, hedging agreements and any structural intra-group loans see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ৩০ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জানু, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £17,350 and all other monies due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The amount satnding from time to time to the credit of the account initially £17,350.50 plus vat. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barco Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ জানু, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ জুন, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over deposit account
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums from time to time credited to the bank account designated easynet limited skee 3RD floor 11 hanover street cash deposit account numbered 70939722 and maintained with barclays bank PLC 50 pall mall london.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Sk Energy Europe Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ মে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £20,386.84 or other sums due or to become due from the company to the chargee as specified in the rent deposit deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The interest of the company in the deposit account and other sums in accordance with clause 4.2 of the rent deposit deed.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barco Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুন, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ জুন, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ নভে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ নভে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ নভে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over book debts
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Specific charge over the benefit of all book debts and other debts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ আগ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £45260 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 8368481 and earmarked or designated by reference to the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ আগ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ আগ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £45,260 and intertest accrued now or to be held by the bank on account numbered 89125606 and earmarked or designated by reference to the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0