GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02955426
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /
    • (7020) /

    GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CROSSCO (NO.115) LIMITED০৩ আগ, ১৯৯৪০৩ আগ, ১৯৯৪

    GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১০

    GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২৮ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nicholas Mark Fletcher Jopling এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৮ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nicholas Peter On এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৮ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter Quentin Patrick Couch এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৭ মে, ২০১১ তারিখে Nicholas Peter On-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mark Greenwood-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Nicholas Mark Fletcher Jopling-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Peter Quentin Patrick Couch-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১২ অক্টো, ২০১০

    ১২ অক্টো, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    ১৬ সেপ, ২০১০ তারিখে Nick On-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Rupert Dickinson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    সচিব
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    Montagu Avenue
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    35
    Tyne And Wear
    পরিচালক
    Montagu Avenue
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    35
    Tyne And Wear
    EnglandBritish74581390003
    GREENWOOD, Mark
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    পরিচালক
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    United KingdomBritish154194730002
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    সচিব
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65421150001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    সচিব
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    MILBURN, Peter Michael
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    সচিব
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    British36406380001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    মনোনীত পরিচালক
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    পরিচালক
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    UkBritish156117090001
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    পরিচালক
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish65421150003
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    পরিচালক
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritish60267600001
    DICKINSON, Stephen
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    পরিচালক
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    United KingdomBritish8256950001
    FIELDER, James
    10 Bishops Road
    SW8 7AB London
    পরিচালক
    10 Bishops Road
    SW8 7AB London
    United KingdomBritish72574940002
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    Chipstead Street
    SW6 3SS London
    28
    পরিচালক
    Chipstead Street
    SW6 3SS London
    28
    EnglandBritish60099210003
    ON, Nicholas Peter
    The Links
    NE26 1RS Whitley Bay
    31
    Tyne And Wear
    পরিচালক
    The Links
    NE26 1RS Whitley Bay
    31
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish135860930002
    SLADE, Sean Anthony
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    পরিচালক
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    British94640230001

    GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The total principle sum of £1,575,000 together with all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings at 179 high street lincoln t/no: LL27733.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Sun Life Assurance Company of Canada (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুন, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুন, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £12,501,016 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of the principal deeds (including for the avoidance of doubt the termination payment) and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of assignment to the lender the benefit f the deposit and subject to the reassignment of the deposit (or such of it is still subsisting and vested in the lender) on repayment to the lender of the loan in full.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Prudential Annuities Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুন, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal sum of £5,607,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge dated 3RD april 1987 and further advances (the "loan") and £1,300,000 due or to become due from the company to the chargee (the "further advance")
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a 1-4 jubilee way winsford cheshire t/no: CH380718.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Prudential Annuities Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal sum of £5,607,000 together with any further advances made by the chargee pursuant to the provisions of the 1987 deed (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property known as queens parade,fountain court and dingle walk,winsford,cheshire; t/nos:CH287801,CH356569,CH384588 and CH402094; the benefit of all rights and/or buildings and all insurances thereto; see form 395 for full details. Undertaking and all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Prudential Annuities Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of release and substitution
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. due or to become due from the company to the chargee and all other monies intended to be secured by the above deed and existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 55 station road clacton.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of release and substitution
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    In favour of the chargee the principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and deeds dated 24TH february 1984, 23 december 1985, 26TH june 1986, 27TH november 1987, 27TH november 1987, 31ST march 1989, 30TH june 1994, 31ST march 1995, 29TH september 1995 and 13TH june 1997 to which it is supplemental
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage f/h property on the south east side of hinckley road coventry t/n-WK352152 together with all buildings and erections and fixtures (including tenants' and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of release and substitution
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুন, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust PLC and all other monies intended to be secured by the deed of release and substitution and the deeds dated 24/2/84, 23/12/85, 26/6/86, 27/11/87, 27/11/87 ,31/3/89, 30/6/94, 31/3/95 and 29/9/95 to which it is supplemental
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h properties k/a 179 high street lincoln and lancaster house 36 orchard street lincoln together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage the l/h land comprising the shopping centre winsford cheshire t/n's CH287801, CH38458 and CH356569 together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon and assigns the goodwill of the business.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Newcastle Building Society
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assignment of rents
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assignment of the benefit of all rents, licence or tenancy fees payable by any lessee, licence or tenant of any part of the shopping centre winsford cheshire (as defined in the mortgage deed of even date).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Newcastle Building Society
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fourth supplemental trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold property known as land and buildings lying to the east of derby road,huyton,merseyside title number MS291314 and a floating charge over all property assets including any uncalled capital and all monies payable under the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Guaradian Royal Exchange Assurance PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুন, ১৯৯৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৪ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Acquisition of property
    তৈরি করা হয়েছে ১২ নভে, ১৯৯৪
    অর্জিত হয়েছে ২৫ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £7,850,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Lancaster house 36 orchard street lincoln t/no LL46183.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Friends Provident Life Office
    ব্যবসায়
    • ১২ নভে, ১৯৯৪অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ২০ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Acquisition of property
    তৈরি করা হয়েছে ১২ নভে, ১৯৯৪
    অর্জিত হয়েছে ২৫ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £7,850,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Winsford town centre cheshire t/no CH287801.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Friends Provident Life Office
    ব্যবসায়
    • ১২ নভে, ১৯৯৪অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ১৯ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    "C" loan notes charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ নভে, ১৯৯৪
    অর্জিত হয়েছে ২৫ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    179 high street lincoln t/no LL27733. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Caroline Patricia Darley Nicola Margaret Combes Rebecca Charlotte Baronas Trustees
    ব্যবসায়
    • ০৮ নভে, ১৯৯৪অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ২০ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    "C" loan notes charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ নভে, ১৯৯৪
    অর্জিত হয়েছে ২৫ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a lancaster house lincoln t/no LL46183 and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Caroline Patricia Darley Nicola Margaret Combes Rebecca Charlotte Baronas Trustees
    ব্যবসায়
    • ০৮ নভে, ১৯৯৪অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ২০ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২২ সেপ, ১৯৮৮
    অর্জিত হয়েছে ১৪ জুন, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £6,850,000.00
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings at queens parade fountain court and dingle walk winsford cheshire t/n-CH287801, CH384588 and CH356569.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Freinds Provident Life Office
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুল, ১৯৯৫অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ১৯ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0