LANNISPORT BRISTOL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLANNISPORT BRISTOL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02957592
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LANNISPORT BRISTOL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য পরিষেবা কার্যক্রম এন.ই.সি. (96090) / অন্যান্য পরিষেবা কার্যক্রম

    LANNISPORT BRISTOL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LANNISPORT BRISTOL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BEG LIMITED১৮ সেপ, ২০০৬১৮ সেপ, ২০০৬
    BUSINESS ENVIRONMENT GROUP LIMITED২০ জানু, ১৯৯৮২০ জানু, ১৯৯৮
    SIRENSTORM LIMITED১১ আগ, ১৯৯৪১১ আগ, ১৯৯৪

    LANNISPORT BRISTOL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৭

    LANNISPORT BRISTOL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    22 পৃষ্ঠাLIQ14

    ০৯ মে, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    16 পৃষ্ঠাLIQ03

    ৩১ মে, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom থেকে 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EUপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ২৮ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে সচিব হিসাবে Haysmacintyre Company Secretaries Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    বিবৃতির বিবৃতি

    8 পৃষ্ঠাLIQ02

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন ১০ মে, ২০১৯ তারিখে

    LRESEX

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ১৮ জুল, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ১৮ ডিসে, ২০১৭ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Lannisport Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    ১৮ ডিসে, ২০১৭ তারিখে Haysmacintyre Company Secretaries Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    ১৮ ডিসে, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom থেকে 10 Queen Street Place London EC4R 1AGপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 150 Minories London EC3N 1LS থেকে Central Point 45 Beech Street London EC2Y 8AD এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    ০৭ আগ, ২০১৭ তারিখে Mr Melvyn Stephen Gilbert-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ জুল, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA

    ১৬ আগ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Haysmacintyre Company Secretaries Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    ১৬ আগ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Simon Michael Rusk এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ১৮ আগ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Jayson Jenkins এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ৩১ জুল, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ২২ জুন, ২০১৬ তারিখে Mr Melvyn Stephen Gilbert-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৫ মার্চ, ২০১৬ তারিখে Mr Melvyn Stephen Gilbert-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে Mr Melvyn Stephen Gilbert-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    LANNISPORT BRISTOL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GILBERT, Melvyn Stephen, Mr
    45 Beech Street
    EC2Y 8AD London
    Central Point
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Beech Street
    EC2Y 8AD London
    Central Point
    United Kingdom
    United KingdomBritishProperty Manager6395630003
    JENKINS, Jayson
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    সচিব
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    165660540001
    KLUG, Bernard Philip
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    সচিব
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    BritishDirector15387060001
    RUSK, Simon Michael, Mr.
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    সচিব
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    British123853770003
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর4682161
    89121630002
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    EMDEN, Andrew Marc
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    পরিচালক
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishAsset Manager126685040002
    GANDY, Nicolas Sean
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    পরিচালক
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United KingdomBritishDirector135709440001
    GERSHINSON, Colin Anthony
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    পরিচালক
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor21890030001
    GLAZER, David Anthony
    No 1 Cecil Road
    Muswell Hill
    N10 2BU London
    পরিচালক
    No 1 Cecil Road
    Muswell Hill
    N10 2BU London
    BritishMoney Broker40730610002
    HEFFERMAN, Graham Anthony
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    পরিচালক
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector140993530001
    JENKINS, Jayson
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    পরিচালক
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant126305070001
    KLUG, Bernard Philip
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    পরিচালক
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director15387060004
    KLUG, Bernard Philip
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    পরিচালক
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    BritishDirector15387060001
    MERCER, Graham Paul
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    পরিচালক
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant108922930002
    RUSK, Simon Michael
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    পরিচালক
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant123853770004
    SAUL, David Gary
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    পরিচালক
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director57597480002
    STEWART, Andrew Lawrence
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12 Groveland Court
    পরিচালক
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12 Groveland Court
    United KingdomBritishDirector23329410002
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    LANNISPORT BRISTOL LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষEngland And Wales
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর05721962
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    LANNISPORT BRISTOL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Leeds Building Society
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Subordination deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from ravencap (no.2) limited to the chargeee on any account whatsoever and all monies due or to become due from ravencap (no.2) limited to the subordinated creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    If any amount of subordinated liabilities is descharged or purported to be discharged by payment, repayment, prepayment, set-off or in any immediately pay it to the agent and pay to the agent an amount equal. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunbar Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ সেপ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Cash of £152,500.00.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland Trust Company (Jersey) Limited & Rbsi Trust Company Limited (Astrustees of the Schroder Emerging Retail Property Unit Trust)
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from business environment basingstoke limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property being those land and buildings k/a viewpoint (formerly berk house) basing view basingstoke hampshire t/no HP202491 and the fixtures. By way of fixed charge all the income, the proceeds of disposal and all deeds and documents, the equipment and goods and assigns the related rights.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Leeds & Holbeck Building Society
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever as agreed in a facility letter dated 26 february 2001
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a newton house 101-113 pentonville road london t/n LN89223; the l/h property k/a view point (formerly berk house) basing view basingstoke hampshire t/n HP202491. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The United Bank of Kuwait PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge all undertaking and assets of the company present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The United Bank of Kuwait PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of rental assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from valleyplace properties limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The right title benefit and interest (whether present or future) in the rent licence fees or other sums of money.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nationwide Building Society
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from valleyplace property limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that property k/a part ground and first-fourth floors, 3-10 market place, reading t/n BK366695. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nationwide Building Society
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    70 to 78 (even) queens road,clifton,bristol together with all buildings thereon and all fixtures subject to and with the benefit of all rights,easements,covenants,restrictions stipulations,agreements,declarations and other matters affecting and/or benefiting the same including every part of the same.specific charge all the income from time to time arising or payable to or on behalf of the company in relation to the property. Assigned to the lender the related rights.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Northern Rock PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ মে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Berk house basing view basingstoke and all fixtures, related rights, fixtures fittings plant and machinery thereon asigns the goodwill and intellectual property. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Northern Rock PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings k/a southbank house black prince road l/b of lambeth greater london t/no: LN141960 and the goodwill of the business the benefit of the licences and the benefits respectively carried on or arising in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Northern Rock PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of rental income
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The aggregate of all amounts payable to or for the benefit or account of the company in connection with the letting of international life house 1 olympic way wembley l/b of brent greater london. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Northern Rock PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of rental income
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The aggregate of all amounts payable to or for the benefit or account of the company in connection with the letting of southbank house black prince road l/b of lambeth greater london. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Northern Rock PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assigns the goodwill of the business the benefit of the licences and by way of floating charge the undertaking and all other property and assets both present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Northern Rock PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings k/a international life house 1 olympic way wembley l/b of brent greater london t/no: NGL46390 and the goodwill of the business the benefit of licences and the benefits carried on or arising in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Northern Rock PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ আগ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a 1 olympic way wembley london t/no: NGL46390 by way of fixed charge all rental income present or future floating charge over. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed of debenture (the "supplemental debenture") which amends the debenture executed on 31ST october 1994 (the "original debenture")
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee of specific liabilities executed by the company on 1ST march 1996 to guarantee the obligations of london and regional property investments limited ("lrpi") under a facility agreement dated 1ST march 1996 entered into between "lrpi" and the bank
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irsih Bank Coporation PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee, indemnity and security assignment agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1. all right to and interest in the goods or other assets subject of the finance lease agreement numbered 134554 dated 26/04/95 2. all the right, title, benefit and interest in and to the finance lease agreement. 3. all other rights and benefits in the above. 4. all rights to sue for damage.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings at southbank house black prince road london SE1 t/n ln 141960 and f/h property k/a 81/103 (odd) euston street and 1/6 regnart buildings london NW1 t/n ngl 236815. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property being the land and buildings at southbank house, black prince road, london SE1 t/no. LN141960 and all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon and any proceeds of any insurance of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Serviced Businesses (Southbank) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ নভে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property being land and buildings k/a 81/103 (odd numbers) euston street and 1/6 regnart buildings, london NW1 t/no. NGL236815 and all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon and any proceeds of any insurance of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Serviced Businesses (Southbank) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ নভে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    LANNISPORT BRISTOL LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১০ মে, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৬ আগ, ২০২১ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Philip Lewis Armstrong
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    অভ্যাসকারী
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Geoffrey Paul Rowley
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    অভ্যাসকারী
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0