CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03002225
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য হোল্ডিং কোম্পানির কার্যক্রম এন.ই.সি. (64209) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম

    CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    6 Jephson Court
    Tancred Close
    CV31 3RZ Leamington Spa
    Warwickshire
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    VILTSTYLE LIMITED১৬ ডিসে, ১৯৯৪১৬ ডিসে, ১৯৯৪

    CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ০৪ অক্টো, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Amount capital reduced be credited to a reserve 29/02/2016
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ১৮ মে, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 100 New Bridge Street London EC4V 6JA থেকে 6 Jephson Court Tancred Close Leamington Spa Warwickshire CV31 3RZপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১০ ফেব, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Abogado Nominees Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২২ ডিসে, ২০১৫

    ২২ ডিসে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 501,175
    SH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Abogado Nominees Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    ২৭ মার্চ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon David Whittaker এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Stephen Lewis-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    16 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১২ জানু, ২০১৫

    ১২ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 501,175
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    16 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ ডিসে, ২০১৩

    ১৮ ডিসে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 501,175
    SH01

    ২৮ সেপ, ২০১৩ তারিখে Simon David Whittaker-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Terrance Helz এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Terrance Helz এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    17 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    17 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Martin Gerard Mullin-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    LEWIS, Paul Stephen
    Tancred Close
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    England
    পরিচালক
    Tancred Close
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    England
    EnglandBritishBusiness Executive163019350001
    MULLIN, Martin Gerard
    c/o Cooper Lighting And Safety Limited
    Wheatley Hall Road
    DN2 4NB Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    c/o Cooper Lighting And Safety Limited
    Wheatley Hall Road
    DN2 4NB Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishBusiness Executive150271550001
    BARKER, Jack
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitors Clerk34404400001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    মনোনীত সচিব
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FORSTER, Robert
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British5336440001
    HELZ, Terrance Valentine
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    সচিব
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    AmericanAttorney61652840001
    THOMASSON, Leigh
    32 Airedale Avenue
    Tickhill
    DN11 9UD Doncaster
    South Yorkshire
    সচিব
    32 Airedale Avenue
    Tickhill
    DN11 9UD Doncaster
    South Yorkshire
    BritishManaging Director41994080003
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর01688036
    900021150001
    BARKER, Jack
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitors Clerk34404400001
    BEYEN, Kris Maria August
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    পরিচালক
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    United KingdomBelgianBusiness Executive157565820001
    BROOK, John Graeme
    Beechtree House
    Burn
    YO8 8LJ Selby
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Beechtree House
    Burn
    YO8 8LJ Selby
    North Yorkshire
    BritishChief Executive48960960001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    মনোনীত পরিচালক
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    মনোনীত পরিচালক
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FORSTER, Robert
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director5336440001
    GAWRONSKI, Grant Lawrence
    19 Hunters Crossing Court
    The Woodlands
    Texas 77381
    Usa
    পরিচালক
    19 Hunters Crossing Court
    The Woodlands
    Texas 77381
    Usa
    UsaAmericanBusiness Executive115387690001
    HAACK, Axel Gottfried Gunther
    9 Haute Corniche
    67210 Obernai
    France
    পরিচালক
    9 Haute Corniche
    67210 Obernai
    France
    GermanBusiness Executive120071580001
    HELZ, Terrance Valentine
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    পরিচালক
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    United StatesAmericanAttorney61652840001
    JONES, Clare Adele
    10 Heddon Place
    Headingley
    LS6 4EL Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    10 Heddon Place
    Headingley
    LS6 4EL Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitor50145210001
    MAXWELL, Peter Willis
    Banbury Road
    CV37 7HW Stratford Upon Avon
    41
    Warwickshire
    পরিচালক
    Banbury Road
    CV37 7HW Stratford Upon Avon
    41
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director60789150004
    PRIESTLEY, Robert
    118 Huddersfield Road
    Brighouse
    HD6 3RH Huddersfield
    পরিচালক
    118 Huddersfield Road
    Brighouse
    HD6 3RH Huddersfield
    EnglandBritishCompany Director109114780001
    SCRIMSHAW, James Eric
    Dove House
    Temple Grafton
    B49 6NT Alcester
    Warwickshire
    পরিচালক
    Dove House
    Temple Grafton
    B49 6NT Alcester
    Warwickshire
    BritishCompany Director60793220002
    SMITH, Gavin David
    144 Pannal Ash Road
    HG2 9AJ Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    144 Pannal Ash Road
    HG2 9AJ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant102540130001
    THOMASSON, Leigh
    Alderson Drive
    Tickhill
    DN11 9HR Doncaster
    2
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Alderson Drive
    Tickhill
    DN11 9HR Doncaster
    2
    South Yorkshire
    EnglandUnited KingdomCompany Director41994080004
    VALE, Michael John
    16 West Hill
    Portishead
    BS20 9QL Bristol
    North Somerset
    পরিচালক
    16 West Hill
    Portishead
    BS20 9QL Bristol
    North Somerset
    BritishSales Director37773560001
    WHITTAKER, Simon David
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director115390050002
    WILKINSON, David Kenworthy
    Barn Cottage Hebers Ghyll Drive
    LS29 9QH Ilkley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Barn Cottage Hebers Ghyll Drive
    LS29 9QH Ilkley
    West Yorkshire
    BritishInvestment Banker30236530001
    WINTERBOTTOM, David Stuart
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    BritishDirector6529580001

    CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite guarantee and mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the finance documents as described in the debenture on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandfor Itself and in Its Capacity as Security Trustee for the Other Beneficiaries as Described in the Debenture
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge all present and future benefits in respect of the policies (as defined) or such other policy or policies as may in accordance with the terms of this charge replace the same from time to time with the payment or discharge of all monies and liabilities hereby covenanted to be paid or discharged by the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ৩১ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ফেব, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    ব্যবসায়
    • ১০ ফেব, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ফেব, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge over on all present and future benefits in respect of the policies - as defined - or such other policy or policies as may in accordance with the terms of this charge replace the same from time to time with the payment or discharge of all monies and liabilities hereby covenanted to be paid or discharged by the company , please see doc for further details,.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    ব্যবসায়
    • ১০ ফেব, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I Plcas Agent for 3I Group PLC and 3I 94 Lmbo Plan
    ব্যবসায়
    • ০৯ ফেব, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0