GREEN PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGREEN PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03007549
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GREEN PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্য কোথাও শ্রেণীবদ্ধ নয় এমন আর্থিক মধ্যস্থতা (64999) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম

    GREEN PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GREEN PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    NORLAND CAPITAL NO.2 LIMITED০৩ মে, ১৯৯৫০৩ মে, ১৯৯৫
    KIRKHAVEN LIMITED০৯ জানু, ১৯৯৫০৯ জানু, ১৯৯৫

    GREEN PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৫

    GREEN PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ৩১ জানু, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Keith Leslie Street এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    9 পৃষ্ঠাLIQ13

    ০৪ সেপ, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    8 পৃষ্ঠাLIQ03

    ০২ মে, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP থেকে 30 Finsbury Square London EC2P 2YUপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ২৮ সেপ, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Ascot House Maidenhead Office Park Maidenhead SL6 3QQ থেকে No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DPপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৫ সেপ, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP

    ০১ আগ, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    ১১ জানু, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Reading International Business Park Basingstoke Road Reading Berkshire RG2 6DB থেকে Ascot House Maidenhead Office Park Maidenhead SL6 3QQপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ২০ নভে, ২০১৫ তারিখে Mr David Gareth Thompson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ মার্চ, ২০১৫ থেকে ৩০ সেপ, ২০১৫ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ২০ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David Gareth Thompson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৫ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Esther Elaine Morley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৩ অক্টো, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে James Harvey Morris এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ৩০ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Arthur Henderson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ আগ, ২০১৫

    ১৯ আগ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    29 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    ৩০ জানু, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Shilla Pindoria এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ৩০ জানু, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kevin Patrick Mckenna এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ জানু, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ms Esther Elaine Morley-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ জানু, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Mr James Harvey Morris-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ৩০ জানু, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Derek Lloyd এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    GREEN PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    THOMPSON, David Gareth
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    পরিচালক
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    United KingdomBritishChartered Accountant203018830001
    MORRIS, James Harvey
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    সচিব
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    194839220001
    MURRAY, Dominic
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    সচিব
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    Other121945810002
    PINDORIA, Shilla
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    সচিব
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    157090000001
    TOMSETT, Ann Sara
    7 Oak Lodge
    Chantry Square
    W8 5UL London
    সচিব
    7 Oak Lodge
    Chantry Square
    W8 5UL London
    British58027970002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    KENSINGTON SECRETARIES LIMITED
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    কর্পোরেট সচিব
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    109008650002
    BLUNDELL, Roger Frederick Crawford
    Vineyard Hill Road
    SW19 7JL London
    61
    পরিচালক
    Vineyard Hill Road
    SW19 7JL London
    61
    EnglandBritishGroup Finance Director56525730002
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    মনোনীত পরিচালক
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    CLAYS, Malcolm
    9 Llewelyn Park
    RG10 9NG Twyford
    Berkshire
    পরিচালক
    9 Llewelyn Park
    RG10 9NG Twyford
    Berkshire
    BritishDirector Of Finance124718190001
    COLSELL, Steven James
    Limes House
    Bytham Road Ogbourne St George
    SN8 1TD Marlborough
    Wiltshire
    পরিচালক
    Limes House
    Bytham Road Ogbourne St George
    SN8 1TD Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritishFinance Director101387770001
    FINEGOLD, Martin Alan
    Lexicon House
    17 Old Court Place
    W8 4PL London
    পরিচালক
    Lexicon House
    17 Old Court Place
    W8 4PL London
    United KingdomAmericanChief Executive125782340001
    FRENCH, Christopher
    Tudor Cottage
    The Green
    OX12 0HQ East Hanney
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Tudor Cottage
    The Green
    OX12 0HQ East Hanney
    Oxfordshire
    BritishDirector80863030001
    HENDERSON, Ian Arthur
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    পরিচালক
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    United KingdomBritishChief Executive207828370001
    HUTCHINSON, Alison
    1 Sheldon Square
    W2 6PU London
    পরিচালক
    1 Sheldon Square
    W2 6PU London
    BritishManaging Director74158760003
    KINGDON, Simon Charles
    64 Waterman's Quay
    William Morris Way
    SW6 2UU London
    পরিচালক
    64 Waterman's Quay
    William Morris Way
    SW6 2UU London
    BritishFinance Director56324870004
    LLOYD, Derek
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    পরিচালক
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    United KingdomBritishHead Of Treasury124660210001
    MALTBY, John Neil
    Priory House
    Priory Close
    BR7 5LB Chislehurst
    Kent
    পরিচালক
    Priory House
    Priory Close
    BR7 5LB Chislehurst
    Kent
    EnglandBritishChief Executive84264890001
    MCKENNA, Kevin Patrick
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    পরিচালক
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    EnglandIrishChief Operating Officer Investec Capital Markets169418850001
    MORLEY, Esther Elaine
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    পরিচালক
    Basingstoke Road
    RG2 6DB Reading
    Reading International Business Park
    Berkshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director150084860001
    PATEL, Anant
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    পরিচালক
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    EnglandBritishInvestment Banker129677000001
    RALPH, Nicholas James
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    পরিচালক
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    United KingdomBritishFinance130070970001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    মনোনীত পরিচালক
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SALTER, Andrew Kershaw
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    পরিচালক
    Gresham Street
    2 Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    United KingdomBritishFinance77737200002
    STREET, Keith Leslie
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    পরিচালক
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    England
    United KingdomBritishHead Of Kensington Mortgages165122930001
    TOMSETT, Ann Sara
    3a Palace Green
    W8 4TR London
    পরিচালক
    3a Palace Green
    W8 4TR London
    EnglandBritishChief Solicitor58027970005
    TOMSETT, Ann Sara
    12 Lower Sawleywood
    SM7 2DB Banstead
    Surrey
    পরিচালক
    12 Lower Sawleywood
    SM7 2DB Banstead
    Surrey
    BritishSolicitor58027970001
    WHEELER, David Antony
    13 Merton Hall Road
    Wimbledon
    SW19 3PP London
    পরিচালক
    13 Merton Hall Road
    Wimbledon
    SW19 3PP London
    EnglandBritishSolicitor108094990001
    WILTEN, Mark Frederick
    26 Maze Road
    TW9 3DE Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    26 Maze Road
    TW9 3DE Richmond
    Surrey
    BritishGroup Treasurer108094190001
    WILTEN, Mark Frederick
    26 Maze Road
    TW9 3DE Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    26 Maze Road
    TW9 3DE Richmond
    Surrey
    BritishGroup Treasurer108094190001

    GREEN PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Kensington Mortgages Limited
    Ascot House, Maidenhead Office Park, Maidenhead,
    SL6 3QQ Maidenhead
    Ascott House
    Berkshire
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Ascot House, Maidenhead Office Park, Maidenhead,
    SL6 3QQ Maidenhead
    Ascott House
    Berkshire
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom
    নিবন্ধিত স্থানCardiff Registry
    নিবন্ধন নম্বর3007549
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    GREEN PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee from time to time under the original facility the dacs 3 term loan and/or the dacs 4 term loan
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its rights and benefits under the custody agreement in and to the the charged securities in and to the collateral accounts and the accounts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental pledge agreement to a pledge agreement originally dated 27TH january 1999 issued by the company
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All liabilites and obligations due or to become due from the pledgors (as defined) to the chargee under the secured term loan facility, the composite debenture, the dacs 3 term loan, the dacs 4 term loan and the dacs comosite debenture as each of the same may be amended or extended from time to time whether before or after 14TH october 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The charged assets being the charged securities and any cash balances standing from time to time to the credit of the collateral account.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed to a composite debenture dated 27 january 1999
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুল, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Prior to conversion, all monies due or to become due from the company and/or any or the other companies named therein to the chargee under the term loan facility and/or the dacs 4 term loan facility and immediately upon conversion, all monies due or to become due from the company and/or any or the other companies to the chargee under the term loan facility
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its rights and benefits under the custody agreement all rights title and interest in and to the charged securities and the collateral accounts and the accounts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জানু, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ফেব, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each a pledgor) to the pledgee under the terms of the debenture and the secured term facility defined therein)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The "charged assets" being the relevant charged securities being the relvant charged securities and any cash balances standing from time to time to thje credit of the collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জানু, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ফেব, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the term loan facility
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its rights and benefits under the custody agreement all rights title and interest in and to the charged securities and the collateral accounts and the accounts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge and assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations of the company (whether actual or contingent, present or future) to the chargee under the term loan agreement dated 9TH february 1998
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of the company's rights and benefits under the custody agreement, all right title and interest in the charged securities and all sums payable in respect thereof, all right title and interest in the ordinary deferred consideration and the special deferred consideration. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Union Bank of Switzerland
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations present and future, actual and contingent of the company to the chargee under the secured term loan agreement dated 5TH february 1998
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The charged assets means the detachable a coupons issued as part of the £63,840,000 class a mortgage back floating rate notes due 2038 issued by residential mortgage securities 3 PLC on 9 february 1998.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Union Bank of Switzerland
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any receiver on any account whatsoever and in particular but without limitation all monies and facilities from time to time due owing or incurred by the company under the facility documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A first fixed equitable charge over the mortgage loans, the deeds, the life policies, the building policies, the miras receipts, the contractual rights, the accounts, the book debts, the tax indemnity, the parent guarantee and undertaking, the causes of action and uncalled capital. By way of first floating charge the whole of the companys undertaking and all its property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Union Bank of Switzerland
    ব্যবসায়
    • ২১ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    GREEN PARK MORTGAGE FUNDING LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৫ সেপ, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১০ এপ্রি, ২০১৮ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    অভ্যাসকারী
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0