SERVASSURE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSERVASSURE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03021117
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SERVASSURE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (6420) /

    SERVASSURE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Greenway House
    Greenway Business Park
    CM19 5QD Pinnacles, Harlow
    Essex
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SERVASSURE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    STERRY COMMUNICATIONS (UK) LIMITED২৫ এপ্রি, ১৯৯৫২৫ এপ্রি, ১৯৯৫
    NEMOURE LIMITED১৩ ফেব, ১৯৯৫১৩ ফেব, ১৯৯৫

    SERVASSURE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৮

    SERVASSURE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed sterry communications (uk) limit ed\certificate issued on 18/02/08
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা190

    SERVASSURE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WEST, Michael David
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    সচিব
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    British112844320001
    WEST, Michael David
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    সচিব
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    British112844320001
    KEAN, Scott Charles
    39 Lawrence Moorings
    CM21 9PE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    39 Lawrence Moorings
    CM21 9PE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British80444700003
    BULTITUDE, David John, Mr.
    The Old Cottage Bucks Hill
    Watford
    WD4 9AE Kings Langley
    Hertfordshire
    সচিব
    The Old Cottage Bucks Hill
    Watford
    WD4 9AE Kings Langley
    Hertfordshire
    British61307690002
    HENWOOD, Julian Richard
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    সচিব
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    British65188860002
    POWER, Mark Peter
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    সচিব
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    British24900380002
    WILKINSON, Alexander Mcnish
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    সচিব
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    British76710610001
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    সচিব
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    British74738270002
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    কর্পোরেট সচিব
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    BLOOMFIELD, Garry James
    Lower Ridge Farm
    Plucksbridge Road
    SK6 7DY Marple
    Cheshire
    পরিচালক
    Lower Ridge Farm
    Plucksbridge Road
    SK6 7DY Marple
    Cheshire
    EnglandBritish43196770002
    DICKER, Timothy Stanley
    260 Rayleigh Road
    SS9 5XL Leigh On Sea
    Essex
    পরিচালক
    260 Rayleigh Road
    SS9 5XL Leigh On Sea
    Essex
    British98850820001
    FOX, John Martin
    The Haven
    Carters Lane
    CM22 6AQ Henham
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Haven
    Carters Lane
    CM22 6AQ Henham
    Hertfordshire
    Great BritainBritish127207050001
    FREEMAN, William Ian Bede
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish64442870001
    GLOVER, Michael John
    Commerce House
    2-6 Bath Street
    Slough
    Berkshire
    পরিচালক
    Commerce House
    2-6 Bath Street
    Slough
    Berkshire
    British2239730001
    KEEVIL, Geoffrey Charles
    65 Shepherds Lane
    HP9 2DU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    65 Shepherds Lane
    HP9 2DU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British19845180001
    TUPMAN, Timothy Alexander
    Highlands
    Berden
    CM23 1AB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Highlands
    Berden
    CM23 1AB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritish67184090006
    WILKINSON, Alexander Mcnish
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    পরিচালক
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    British76710610001
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    British74738270002
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000930001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001

    SERVASSURE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and all monies and liabilities due or to become due from sterry group limited, sterry holdings limited and the company to the chargee on any account whatsoever in accordance with the terms of the deferred consideration agreement dated on or around 24TH march 2000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • !Siemens Communications Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২২ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of assignment any monies payable to the bank for or in connection with the disposal (by way of sale or otherwise) of any chattels the chattels :-nom code 70182 pd no 08/93 invoice date FEB93 internal ref 210762 invoice VALUE6,270,00 david polland asset description 610MB 498/33. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0