REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামREDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03021292
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Central House
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    North Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED০৬ ফেব, ২০০২০৬ ফেব, ২০০২
    REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED১৭ ডিসে, ২০০১১৭ ডিসে, ২০০১
    REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED ২১ ডিসে, ২০০০২১ ডিসে, ২০০০
    REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED১৪ ফেব, ১৯৯৫১৪ ফেব, ১৯৯৫

    REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০২০

    REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    ১০ ডিসে, ২০২০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    3 পৃষ্ঠাSH19

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium account be cancelled 18/11/2020
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ০৩ এপ্রি, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Dean Anthony Barber এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৩ ফেব, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০২ সেপ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Dean Anthony Barber-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ১৩ ফেব, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ০৩ সেপ, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Peter Brotherton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৩ সেপ, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Harneet Jagpal-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ১৪ ফেব, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ২০ অক্টো, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Fraser St John Fisher এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ ফেব, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ২৮ নভে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Peter James Brotherton-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৮ নভে, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Peter Brotherton-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০৬ নভে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Timothy James Coleman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৬ নভে, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Timothy James Coleman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    JAGPAL, Harneet
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    সচিব
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    250198230001
    BROTHERTON, Peter James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish116701310002
    BRACHER, Alan Richard
    53 Foley Road
    KT10 0LU Claygate
    Surrey
    সচিব
    53 Foley Road
    KT10 0LU Claygate
    Surrey
    British36451680001
    BROTHERTON, Peter
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    সচিব
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    220552440001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    সচিব
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    210014290001
    CROFT, Estelle Louise
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    সচিব
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    195008160001
    HARROLD, Alan Henry
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    সচিব
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    British88772110001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    সচিব
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    164939920001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    সচিব
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    MYHILL, Paul Harvey
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    সচিব
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    175306270001
    O'RORKE, Nicholas
    Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B-Office 10 Kirtlington Business Centre
    Oxfordshire
    সচিব
    Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B-Office 10 Kirtlington Business Centre
    Oxfordshire
    149441960001
    VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr.
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    সচিব
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British80721980001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    পরিচালক
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish82233550001
    BARBER, Dean Anthony
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish230739040001
    BROWN, Ian Christopher
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    পরিচালক
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish75493580001
    BRUCE, Robert David Glenrinnes
    45 Gally Hill Road
    Church Crookham
    GU13 0QE Fleet
    Hampshire
    পরিচালক
    45 Gally Hill Road
    Church Crookham
    GU13 0QE Fleet
    Hampshire
    British66210170001
    BYAM SHAW, Justin David Elliott
    6 Westbourne Park Road
    W2 5PH London
    পরিচালক
    6 Westbourne Park Road
    W2 5PH London
    British40017100001
    CARRINGTON, John Christopher
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    পরিচালক
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritish79087670001
    CHATFIELD, Paul
    21 Ludlow Avenue
    WR4 0EN Worcester
    Worcestershire
    পরিচালক
    21 Ludlow Avenue
    WR4 0EN Worcester
    Worcestershire
    British71912610001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    পরিচালক
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish163698620001
    COVE, Graham Lawrence
    2 White House Close
    SG14 3TW Watton At Stone
    Hertfordshire
    পরিচালক
    2 White House Close
    SG14 3TW Watton At Stone
    Hertfordshire
    EnglandBritish45340010002
    COX, David Howard
    Waverley
    Chenies Road Chorleywood
    WD3 5LU Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Waverley
    Chenies Road Chorleywood
    WD3 5LU Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish100698330001
    CUSHING, Robert Sefton
    66 Columbia Place Fornham Street
    S2 4AR Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    66 Columbia Place Fornham Street
    S2 4AR Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish117325300001
    DAWSON, John Hugh
    Ashleigh
    Grenofen
    PL19 9EW Tavistock
    Devon
    পরিচালক
    Ashleigh
    Grenofen
    PL19 9EW Tavistock
    Devon
    EnglandBritish59251210001
    DEANE, Keith
    2 Westminster Close
    GU51 4NR Fleet
    Hampshire
    পরিচালক
    2 Westminster Close
    GU51 4NR Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish85309310001
    DONNELLY, Mary Kathleen
    Prospect House
    1a Prospect Row
    CB1 1DU Cambridge
    পরিচালক
    Prospect House
    1a Prospect Row
    CB1 1DU Cambridge
    EnglandBritish85309000001
    DOUGHTY, Royston George
    60 Cedars Road
    Hampton Wick
    KT1 4BE Kingston Upon Thames
    Surrey
    পরিচালক
    60 Cedars Road
    Hampton Wick
    KT1 4BE Kingston Upon Thames
    Surrey
    British6194830001
    DOWNHAM, Robert Henry
    Spring Cottage
    The Common
    DT11 8QY Blandford Forum
    Dorset
    পরিচালক
    Spring Cottage
    The Common
    DT11 8QY Blandford Forum
    Dorset
    British98701880001
    FISHER, Fraser St John
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish72704710002
    GRAY, Christopher Robert
    15 Vale Close
    Lower Bourne
    GU10 3HR Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    15 Vale Close
    Lower Bourne
    GU10 3HR Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish23552180001
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish20621770002
    HARROLD, Alan Henry
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish88772110001
    LANCH, Nigel Leslie
    Willow Cottage 19 Water Lane
    KT11 2PA Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    Willow Cottage 19 Water Lane
    KT11 2PA Cobham
    Surrey
    British54508950001
    MCGOUGAN, Malcolm James Andrew
    33 Shrub End Road
    CO3 3UD Colchester
    Essex
    পরিচালক
    33 Shrub End Road
    CO3 3UD Colchester
    Essex
    British44066820001
    MOONEY, Jeremy
    135 Victoria Road
    N22 7XH London
    পরিচালক
    135 Victoria Road
    N22 7XH London
    British71912690001

    REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Redcentric Holdings Limited
    Otley Road
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Otley Road
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Ground floor, building no. 3 (newton house), the cambridge business park, milton road, cambridge t/no CB340008. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০২ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুন, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুন, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ ডিসে, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ফেব, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge the charged securities, any related rights, dividends, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০২ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০২ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুল, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুল, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুল, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০২ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £22,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Deposit of £22,500 and all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Goodall Barnard Holdings Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £12,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £12,500 deposit with all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Goodall Barnard Holdings Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £15,000.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £15,000 deposit and all other moneys demanded and all interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Goodall Barnard Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease granted on the same date as the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit is defined in the deed as the sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £25,375,00 paid by the tenant under the deed, any renewal or replacement of these sums, all interest earned on the account and all entitlements, rights and benefits accruing directly or indirectly to the account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • South Herts Office Campus Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ মে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২১ আগ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date relating to the property known as third floor unit b south herts office campus borehamwood
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A deposit of £33,876 and accruing interest. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ আগ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities of the obligors to the chargee under each of the finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest in and to the equipment all benefits in respect of the insurances and all proceeds thereof for full details and definitions please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dresdner Bank Ag
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The tenant charges its interest in the deposit balance.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Computer Associates UK Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The sum of £61,117 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Computer Associates UK Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The due compliance of the company's obligations with the chargee under the lease dated 16TH july 1998
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £27,354.25 deposited at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london together with any interest accrued.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £482,925 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Three okeford switches.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Planet Internet (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৫ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 27TH february 1996
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Deposit of £18,175 maintained at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london tigether with all interest accruing. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0