LGL 1996 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLGL 1996 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03034136
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LGL 1996 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    LGL 1996 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LGL 1996 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    LUXFER GROUP 1996 LIMITED০৩ জুল, ২০০০০৩ জুল, ২০০০
    LUXFER GROUP LIMITED০৩ অক্টো, ১৯৯৭০৩ অক্টো, ১৯৯৭
    BRITISH ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED০৪ ডিসে, ১৯৯৫০৪ ডিসে, ১৯৯৫
    DMWSL 159 LIMITED১৬ মার্চ, ১৯৯৫১৬ মার্চ, ১৯৯৫

    LGL 1996 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৬

    LGL 1996 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    25 পৃষ্ঠাMA

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Anchorage Gateway 5 Anchorage Quay Salford M50 3XE থেকে Lumns Lane Manchester M27 8LNপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২২ ফেব, ২০১৮ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.01
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    ০১ জানু, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Jamie Mark Savage-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০১ জানু, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে David Nicholas Fletcher এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ১৫ ডিসে, ২০১৭ তারিখে David Nicholas Fletcher-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ১৫ ডিসে, ২০১৭ তারিখে Mr Brian Gordon Purves-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩০ সেপ, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ সেপ, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ০৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে David Nicholas Fletcher-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    ০৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Linda Frances Seddon এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ সেপ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ অক্টো, ২০১৫

    ২৬ অক্টো, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ অক্টো, ২০১৪

    ১৭ অক্টো, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    LGL 1996 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SAVAGE, Jamie Mark
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    সচিব
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    241848520001
    PURVES, Brian Gordon
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    পরিচালক
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    EnglandBritish47456240002
    BURNS, Richard
    Scalebor House
    Moor Lane
    LS29 7AF Burley In Wharfedale
    সচিব
    Scalebor House
    Moor Lane
    LS29 7AF Burley In Wharfedale
    British60673970003
    DEMBLOWSKI, Denis Anthony
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    সচিব
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    American82569240001
    FLETCHER, David Nicholas
    5 Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    সচিব
    5 Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    206178230001
    SEDDON, Linda Frances
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    সচিব
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    British14578300002
    SEDDON, Linda Frances
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    সচিব
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    British14578300002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    15th Floor
    Moor House 119 London Wall
    EC2Y 5ET London
    কর্পোরেট সচিব
    15th Floor
    Moor House 119 London Wall
    EC2Y 5ET London
    67382580001
    BOYLE, Tobias Humphrey James
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    পরিচালক
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    EnglandBritish141831310001
    COMFORT, William Twyman
    Flat 1
    38 Pont Street
    SW1 London
    পরিচালক
    Flat 1
    38 Pont Street
    SW1 London
    British53760460001
    DEMBLOWSKI, Denis Anthony
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    পরিচালক
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    American82569240001
    FARGAS MAS, Lluis Maria
    Rue De Lausanne 62
    Morges
    Vaud 1110
    Switzerland
    পরিচালক
    Rue De Lausanne 62
    Morges
    Vaud 1110
    Switzerland
    SwitzerlandSpanish72852990001
    FAULL, Ian Trevor
    West Chalet Groves Avenue
    Langland
    SA3 4QF Swansea
    West Glamorgan
    পরিচালক
    West Chalet Groves Avenue
    Langland
    SA3 4QF Swansea
    West Glamorgan
    United KingdomBritish12734690001
    JACOB, Frances Carol
    11 Augustus Court
    Augustus Road Southfields
    SW19 6NA London
    পরিচালক
    11 Augustus Court
    Augustus Road Southfields
    SW19 6NA London
    British38154840001
    MACKENZIE, Alexander Donald
    Shalden Lodge
    Shalden Lane Shalden
    GU34 4DU Alton
    Hampshire
    পরিচালক
    Shalden Lodge
    Shalden Lane Shalden
    GU34 4DU Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish105120270001
    MCKAY, Francis John
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    পরিচালক
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    British78787530001
    MCKINNON, Ian Bannochie
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    পরিচালক
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritish980160001
    MCKINNON, Ian Bannochie
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    পরিচালক
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritish980160001
    MITCHELL, Raymond Barnes
    Av De Florimont
    20 Bis 1006
    FOREIGN Lausanne
    Switzerland
    পরিচালক
    Av De Florimont
    20 Bis 1006
    FOREIGN Lausanne
    Switzerland
    American72854970001
    MURRAY, Norman Loch
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    পরিচালক
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    ScotlandBritish22920002
    MURRAY, Norman Loch
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    পরিচালক
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    ScotlandBritish22920002
    PURVES, Brian Gordon
    72a Macclesfield Road
    SK10 4BH Prestbury
    Cheshire
    পরিচালক
    72a Macclesfield Road
    SK10 4BH Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish47456240002
    WHALLEY, Jeffrey
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    পরিচালক
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritish1955430002
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    কর্পোরেট পরিচালক
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    LGL 1996 LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    5, Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    5, Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Company Limited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland & Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUk Companies Act
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর3944037
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    LGL 1996 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage of shares
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All indebtedness and liabilities of any nature of each charging company (as defined) to the chargee (as security agent and trustee for itself and the other senior finance parties) and/or any of the senior finance parties (as defined) and/or any receiver under or in connection with the senior finance documents (as defined) including without limitation,under any amendments,supplements,or restatements of any of the senior finance documents including any containing provision for new or further advances)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Ordinary shares of 1 irish pound each in luxfer overseas holding limited and luxfer group limited all other securities rights and monies including without limitation dividends please refer to form 395 for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৮ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All indebtedness and other liabilities of any nature of each charging company (as defined) to the chargee in it's capacity as security agent for itself and the other senior finance parties (as defined) and/or any of the senior finance parties and/or any receiver under or in connection with the senior finance documents (as defined) (including without limitation, under any amendments, supplements or restatements of any of the senior finance documents including any containing provision for new or further advances)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ আগ, ২০০০বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৩ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture subject to and with the benefit of the intercreditor agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the chargee under the finance documents (or any of them)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Agent and Trustee for Itself and the Other Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ১৪ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0