PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03035572
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7020) /

    PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PENN HOUSE (CHELTENHAM) LIMITED ১৭ নভে, ১৯৯৯১৭ নভে, ১৯৯৯
    WOODSFORD PROPERTIES (CHELTENHAM) LIMITED১৬ জানু, ১৯৯৬১৬ জানু, ১৯৯৬
    WOODSFORD PROPERTIES (EDINBURGH) LIMITED২১ মার্চ, ১৯৯৫২১ মার্চ, ১৯৯৫

    PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০০৯

    PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০১ মে, ২০১০ তারিখে Christopher George White-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ মে, ২০১০ তারিখে Mr Maurice Moses Benady-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ২১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১১ মে, ২০১০

    ১১ মে, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    ২১ মার্চ, ২০১০ তারিখে Trafalgar Officers Limited-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH02

    ০৯ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Reit(Corporate Services) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা190

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    4 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    4 পৃষ্ঠা288a

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    কর্পোরেট সচিব
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    পরিচালক
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritishSolicitor69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    পরিচালক
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishBarrister-At-Law80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর6745658
    135316290001
    DENHAM, Timothy Maurice
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    সচিব
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    British51492670001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    সচিব
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    BritishAccountant74688330002
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    সচিব
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    BritishCompany Director2942350001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    সচিব
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BONAVERO, Yves Jean Marc
    54 St James`S Gardens
    W11 4RA London
    পরিচালক
    54 St James`S Gardens
    W11 4RA London
    EnglandFrenchCompany Director29119190003
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    পরিচালক
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director11296610002
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director116927100001
    DUMAS, Markham Cresswell
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    পরিচালক
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director31098150001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    পরিচালক
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishChief Accountant163838050001
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    পরিচালক
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    United KingdomBritishCompany Director2942350001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor60687110001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    কর্পোরেট পরিচালক
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২৯ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a unit 1 ravensbank business park ravensbank drive redditch t/n WR58721. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0