GRIPPERRODS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGRIPPERRODS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03041925
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GRIPPERRODS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    GRIPPERRODS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GRIPPERRODS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ARLESHAW LIMITED০৪ এপ্রি, ১৯৯৫০৪ এপ্রি, ১৯৯৫

    GRIPPERRODS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    GRIPPERRODS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    GRIPPERRODS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    8 পৃষ্ঠা4.71

    ১৫ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    8 পৃষ্ঠা4.68

    ১৫ আগ, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    8 পৃষ্ঠা4.68

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন

    LRESSP

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ ডিসে, ২০১২

    ১৭ ডিসে, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 9,806,459
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    21 পৃষ্ঠাCC04

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    23 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    9 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Michael Hopster এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Elizabeth Honor Lewzey-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Michael John Hopster এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৪ জুল, ২০১১ তারিখে Elizabeth Honor Lewzey-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Nicolas Paul Wilkinson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Thomas C. Reeve-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Elizabeth Honor Lewzey-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Paul Flanagan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Denise Burton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Michael John Hopster-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    GRIPPERRODS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    সচিব
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    165833030001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    পরিচালক
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish59381700003
    REEVE, Thomas C.
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    পরিচালক
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    United StatesAmerican161822390001
    WILKINSON, Nicolas Paul
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    পরিচালক
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish48808690001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    সচিব
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570004
    HOPSTER, Michael John
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    সচিব
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    157103010001
    LAU, Cheong Koon
    40 Strongbow Road
    Eltham
    SE9 1DT London
    সচিব
    40 Strongbow Road
    Eltham
    SE9 1DT London
    Malaysian16337610001
    PAUL, Simon George
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    সচিব
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    British154423590001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    পরিচালক
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish47432570004
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    পরিচালক
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    FARRELL, William Michael
    7 Craigvale Court
    DG1 4QH Dumfries
    পরিচালক
    7 Craigvale Court
    DG1 4QH Dumfries
    British62063670001
    FLANAGAN, Paul Edward
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    পরিচালক
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    United KingdomBritish69281780002
    HAZARD, George Anthony
    46 Broad Oaks Road
    B91 1JB Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    46 Broad Oaks Road
    B91 1JB Solihull
    West Midlands
    British6369950001
    HOPSTER, Michael John
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    পরিচালক
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    United KingdomBritish77921850004
    HOUGHTON, Paul David
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    পরিচালক
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    British95097460001
    JACKSON, Pearse
    3 Woodside
    Parkgate
    DG1 3LY Dumfries
    পরিচালক
    3 Woodside
    Parkgate
    DG1 3LY Dumfries
    Irish61362400001
    LEES, Peter Bryce
    6 Jerviswood
    ML1 4AJ Motherwell
    Lanarkshire
    পরিচালক
    6 Jerviswood
    ML1 4AJ Motherwell
    Lanarkshire
    British26615220001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MOULDS, Peter John
    2 Millside
    Slitting Mill
    WS15 2FG Rugeley
    Staffordshire
    পরিচালক
    2 Millside
    Slitting Mill
    WS15 2FG Rugeley
    Staffordshire
    British31029500002
    OWEN, David Evan Penrhyn
    The Old Barn
    Church Lane
    S81 9EH Carlton In Lindrick
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    The Old Barn
    Church Lane
    S81 9EH Carlton In Lindrick
    Nottinghamshire
    British73849580001
    PAUL, Simon George
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    EnglandBritish154423590001
    PERSSON, Jan Allan
    3 Wayside
    SW14 7LN London
    পরিচালক
    3 Wayside
    SW14 7LN London
    Swedish6650000001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    পরিচালক
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    ROBB, Kenneth
    2 Glentruim View
    KA2 0LL Kilmarnock
    Ayrshire
    পরিচালক
    2 Glentruim View
    KA2 0LL Kilmarnock
    Ayrshire
    British61362350001
    SACK, Adam David
    115 Broadhurst Gardens
    NW6 3BJ London
    পরিচালক
    115 Broadhurst Gardens
    NW6 3BJ London
    British32459700002
    STANSFIELD, Neil Andrew
    The Laurels, Poets Way
    Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    পরিচালক
    The Laurels, Poets Way
    Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British79347560001
    WIEGMAN, Albert Edward Bernard
    17 Hills Avenue
    CB1 7UY Cambridge
    পরিচালক
    17 Hills Avenue
    CB1 7UY Cambridge
    British7466220002
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    GRIPPERRODS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £33,000 together with interest accrued now or to be held by national westmister bank PLC on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ অক্টো, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জানু, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under this mortgage debenture or in connection with a counter indemnity of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Eac Fund I Gp Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ অক্টো, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £41,300 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ অক্টো, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an invoice discounting agreement (as therein defined) or otherwise
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed equitable charge (I) all debts the subject of an invoice discounting agreement between the company and the chargee that fail to vest in the chargee and all rights in favour of the company related to such debts and (ii) all other amounts owing and all rights relating to such amounts, floating charge such of the moneys received in respect of amounts referred to in (ii) above as shall stand released from the fixed equitable charge.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee under the terms of a credit sale agreement dated 12TH september 1991 and a novation agreement dated 5TH june 1995
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sponge rubber underlay production line situated at the company's premises at walkmill lane, cannock, staffordshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mercat Industrial Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুল, ১৯৯৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২১ মে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Factory warehouse and office premises forming part of the industrial estate at walkmill lane cannock staffordshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ অক্টো, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    GRIPPERRODS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৬ আগ, ২০১৩ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৬ ফেব, ২০১৬ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    অভ্যাসকারী
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0