OVUM LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামOVUM LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03068678
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    OVUM LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম
    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    OVUM LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    5 Howick Place
    SW1P 1WG London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    OVUM LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    OVUM LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    OVUM LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ১৫ সেপ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Reduction share premium acc, company's share based payment acc & company's revaluation reserve acc 07/09/2015
    RES13

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৬ জুল, ২০১৫

    ১৬ জুল, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 6,186,690
    SH01

    ০১ জুন, ২০১৫ তারিখে Mr Rupert John Joseph Hopley-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জুন, ২০১৫ তারিখে Miss Julie Louise Woollard-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ জুন, ২০১৫ তারিখে Mr Gareth Richard Wright-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জুন, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Mortimer House 37-41 Mortimer Street London W1T 3JH থেকে 5 Howick Place London SW1P 1WGপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    চার্জ 1 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    3 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 2 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    3 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 5 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    3 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 3 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    3 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 4 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    3 পৃষ্ঠাMR04

    ৩১ ডিসে, ২০১৪ তারিখে Rupert John Joseph Hopley-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ ডিসে, ২০১৪ তারিখে Rupert John Joseph Hopley-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৬ জুন, ২০১৪

    ১৬ জুন, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 6,186,690
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Emily Martin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Peter Rigby এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Adam Walker এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    OVUM LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WOOLLARD, Julie Louise
    5 Howick Place
    SW1P 1WG London
    Informa Plc
    United Kingdom
    সচিব
    5 Howick Place
    SW1P 1WG London
    Informa Plc
    United Kingdom
    British139159370002
    HOPLEY, Rupert John Joseph
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    পরিচালক
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor115999260001
    WRIGHT, Gareth Richard
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    পরিচালক
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant131115190002
    BOXER, Karen Lesley
    166 Dukes Avenue
    Muswell Hill
    N10 2QB London
    সচিব
    166 Dukes Avenue
    Muswell Hill
    N10 2QB London
    British29531980002
    MARTIN, Emily Louise
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    সচিব
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    160701750001
    MCKENZIE, Thomas Dale
    Brook House
    Church Lane
    TN12 5JU East Peckjam
    Kent
    সচিব
    Brook House
    Church Lane
    TN12 5JU East Peckjam
    Kent
    British81816310001
    NIXON, Rowena Jane
    52 Kilworth Avenue
    Shenfield
    CM15 8PT Brentwood
    Essex
    সচিব
    52 Kilworth Avenue
    Shenfield
    CM15 8PT Brentwood
    Essex
    BritishCompany Secretary77821000001
    RICHMOND, Sonia Anna
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    সচিব
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    British118535490002
    DATAMONITOR SECRETARIES LIMITED
    Charles House
    108-110 Finchley Road
    NW3 5JJ London
    কর্পোরেট সচিব
    Charles House
    108-110 Finchley Road
    NW3 5JJ London
    116374750001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BURTON, John William
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    পরিচালক
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    United KingdomBritishGeneral Counsel/Lawyer113684810001
    CARLESS, Tom Edward
    3 Chapmans Lea
    Aston Abbotts
    HP22 4LQ Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    3 Chapmans Lea
    Aston Abbotts
    HP22 4LQ Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinance Director174158800001
    CRAGG, Bernard Anthony
    30 Claremont Road
    N3 1TH London
    পরিচালক
    30 Claremont Road
    N3 1TH London
    BritishChartered Accountant5029640003
    DANSON, Michael Thomas
    Charles House 108-110 Finchley Road
    Swiss Cottage
    NW3 5JJ London
    পরিচালক
    Charles House 108-110 Finchley Road
    Swiss Cottage
    NW3 5JJ London
    BritishDirector16134990006
    DARABI, Farshid
    43 Richmond Road
    EN5 1SF New Barnet
    Hertfordshire
    পরিচালক
    43 Richmond Road
    EN5 1SF New Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector89004350003
    DAWSON, Stephen John Rodgers
    17 New Row
    WC2N 4LA London
    পরিচালক
    17 New Row
    WC2N 4LA London
    United KingdomBritishInvestment Manager70687580002
    DINES, Christopher John
    54 Balcaskie Road
    Eltham
    SE9 1HQ London
    পরিচালক
    54 Balcaskie Road
    Eltham
    SE9 1HQ London
    EnglandBritishChartered Accountant55025500001
    FOYE, Anthony Martin
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    পরিচালক
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector99515780001
    FURLONGER, Jonathan
    19 Copse Edge
    GU6 7DU Cranleigh
    Surrey
    পরিচালক
    19 Copse Edge
    GU6 7DU Cranleigh
    Surrey
    BritishDirector89260810001
    GILBERTSON, David Stuart
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    পরিচালক
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    United KingdomBritishDirector10921820004
    GLENNON, Fiona Margaret
    Flat 11 Cranfield House
    97-107 Southampton Row
    WC1B 4HH London
    পরিচালক
    Flat 11 Cranfield House
    97-107 Southampton Row
    WC1B 4HH London
    EnglandBritishDirector93117220001
    HARROP, Peter John, Dr
    Isis Wingate Road
    Long Sutton
    RG25 1SZ Basingstoke
    Hampshire
    পরিচালক
    Isis Wingate Road
    Long Sutton
    RG25 1SZ Basingstoke
    Hampshire
    BritishNon Executive Director14844270001
    HEWETT, Julian John
    77 Kitto Road
    SE14 5TN London
    পরিচালক
    77 Kitto Road
    SE14 5TN London
    EnglandBritishIt Consultant29532010001
    HOLWAY, Richard William
    4 Swifts Close
    Compton Way Moor Park
    GU10 1QX Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    4 Swifts Close
    Compton Way Moor Park
    GU10 1QX Farnham
    Surrey
    EnglandBritishDirector17878010002
    INGRAM, Patricia Mary
    Flat 2 57 Shirland Road
    W9 2JD London
    পরিচালক
    Flat 2 57 Shirland Road
    W9 2JD London
    BritishIt Consultant41439790001
    JACOBS, Rachel Elizabeth
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    পরিচালক
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritishCompany Secretary92334500004
    JOHNSON, Christopher Timothy Forbes
    14 Penn Road
    N7 9RD London
    পরিচালক
    14 Penn Road
    N7 9RD London
    EnglandBritishIt Consultant13519490001
    JONES, Frank Stevenson
    37 Middlefield Lane
    Hagley
    DY9 0PY Stourbridge
    পরিচালক
    37 Middlefield Lane
    Hagley
    DY9 0PY Stourbridge
    United KingdomBritishDirector11021040001
    KEE, Richard Irvine, Dr
    166 Dukes Avenue
    Muswell Hill
    N10 2QB London
    পরিচালক
    166 Dukes Avenue
    Muswell Hill
    N10 2QB London
    BritishIt Consultant29532000002
    KERSWELL, Mark Henry
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    পরিচালক
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritishDirector82609620003
    LAMBERT, Garvin Richard
    13 Frewin Road
    SW18 3LR London
    পরিচালক
    13 Frewin Road
    SW18 3LR London
    BritishSales And Marketing Manager38297290001
    LEWIN, David Michael
    17 St Pauls Crescent
    NW1 9XN London
    পরিচালক
    17 St Pauls Crescent
    NW1 9XN London
    BritishIt Consultant29531990002
    NEWPORT, William M
    9492 Oak Falls Court
    VA 22066 Great Falls
    Usa
    পরিচালক
    9492 Oak Falls Court
    VA 22066 Great Falls
    Usa
    UsaCompany Director53025600001
    NICHOLS, Margaret Eirwen
    64 Green Dragon Lane
    N21 2LH London
    পরিচালক
    64 Green Dragon Lane
    N21 2LH London
    BritishIt Consultant38297220001
    PYPER, Simon John
    56 Greenfield Gardens
    Golders Green
    NW2 1HY London
    পরিচালক
    56 Greenfield Gardens
    Golders Green
    NW2 1HY London
    BritishFinance Director108173190002

    OVUM LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of accession and charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Letter of pledge over a deposit
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Maximum sum of £220,000 being the cash deposit in account number 00987988 held in the name of ovum holdings limited held at the bank of scotland st james gate 14-16 cockspur street london together with all interest benefits and bonuses due thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৯ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0