OAKGATE PROPERTIES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামOAKGATE PROPERTIES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03077617
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    OAKGATE PROPERTIES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    OAKGATE PROPERTIES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Castlegarth Grange
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    OAKGATE PROPERTIES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    LANDCLASS LIMITED১০ জুল, ১৯৯৫১০ জুল, ১৯৯৫

    OAKGATE PROPERTIES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৬

    OAKGATE PROPERTIES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ১০ জুল, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১২ মে, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Oakgate House 25 Market Place Wetherby West Yorkshire LS22 6LQ থেকে Castlegarth Grange Scott Lane Wetherby LS22 6LHপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ মার্চ, ২০১৭ থেকে ৩১ আগ, ২০১৭ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ১৬ জানু, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে John David Grantham এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ জুল, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুল, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ জুল, ২০১৫

    ২৯ জুল, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000
    SH01

    ০১ জানু, ২০১৫ তারিখে Mr John David Grantham-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জানু, ২০১৫ তারিখে Mr Richard Edward France-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জানু, ২০১৫ তারিখে Mr Paul Caddick-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    ২০ জানু, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Paul Andrew Bullers-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ২০ জানু, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter Graham Hirst এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ জানু, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Andrew Bullers-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২০ জানু, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Peter Graham Hirst এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৫ জুল, ২০১৪

    ২৫ জুল, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুল, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ জুল, ২০১৩

    ২৯ জুল, ২০১৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুল, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    OAKGATE PROPERTIES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BULLERS, Paul Andrew
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    সচিব
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    194298910001
    BULLERS, Paul Andrew
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    পরিচালক
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    EnglandBritish155801480001
    CADDICK, Paul
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    পরিচালক
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    United KingdomBritish2288420001
    FRANCE, Richard Edward
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    পরিচালক
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    United KingdomBritish56208840002
    HIRST, Peter Graham
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    British32603370002
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003220001
    GRANTHAM, John David
    Oakgate House
    25 Market Place
    LS22 6LQ Wetherby
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Oakgate House
    25 Market Place
    LS22 6LQ Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish48928850002
    HIRST, Peter Graham
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish32603370002
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    OAKGATE PROPERTIES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Caddick Group Plc
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    West Yorkshire
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    West Yorkshire
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland
    নিবন্ধন নম্বর02065043
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ২৫% এর বেশি কিন্তু ৫০% এর বেশি নয় শেয়ারের মালিকানাধীন।
    Oakgate Group Plc
    Market Place
    LS22 6LQ Wetherby
    Oakgate House
    West Yorkshire
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Market Place
    LS22 6LQ Wetherby
    Oakgate House
    West Yorkshire
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland
    নিবন্ধন নম্বর03055772
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৫০% এর বেশি কিন্তু ৭৫% এর বেশি নয় শেয়ারের মালিকানাধীন।

    OAKGATE PROPERTIES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 19 december 1997
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    7 blake street york together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জানু, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জানু, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 19TH december 1997
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Stonegate walk stonegate york-NYK11567 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein ("group member") to the chargees on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies from time to time due or owing or incured to the company under the occupational leases in respect of 26,28 and 30 stonegate york t/no's;-NYK29311. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited(as Trustee for Itself and the Other Lenders)
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due by any group member to the chargees supplemental to the legal charge dated 19TH december 1997 between oakgate group PLC and norwich union mortgage finance limited
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    26,28 and 30 stonegate york t/no;-NYK29311 together with all buildings fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) fixed plant and machinery all improvements and additions thereto benefits under all leases and licences in relation to the property. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited(As Trustee for Itself and Any Other Lenders from Time to Time)
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplemental deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge which is supplemental to the principal deed dated 19TH december 1997
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a units e,f and g 25/27 market place wetherby west yorkshire together with all buildings erections and fixtures (including trade but excluding tenant's fixtures) fixed plant machinery all improvements and additions thereto all rights and licences benefits of all leases underleases tenancies agreements to lease covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance and floating charge the whole of the company's undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Memorandum of cash deposit
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Initial deposit of £280,000 credited to acct/no 00219229 with the bank and any addition to that deposit in any currency.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Memorandum of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The amount from time to time standing to the credit of account number 00219210 with the bank and any deposit from time to time of the company with the bank of any other currency description designation or numbering etc.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Memorandum of cash deposit
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The amount from time to time standing to the credit of account number 00219237 with the bank and any deposit from time to time of the company with the bank of any other currency description designation or numbering etc.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 7 - 11 trinity street (formerly k/a the ostlers arms) leeds t/no wyk 521321 with the goodwill of the business and proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0