PRINT REALISATIONS 2011 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPRINT REALISATIONS 2011 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03082845
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PRINT REALISATIONS 2011 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (2222) /

    PRINT REALISATIONS 2011 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1-2 Little King Street
    BS1 4HW Bristol
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PRINT REALISATIONS 2011 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    N.G.S. PRINT FINISHERS LIMITED২৪ জুল, ১৯৯৫২৪ জুল, ১৯৯৫

    PRINT REALISATIONS 2011 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ আগ, ২০০৯

    PRINT REALISATIONS 2011 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ০২ জুল, ২০১২ তারিখে প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    12 পৃষ্ঠা2.35B

    ০১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    12 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ০১ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    11 পৃষ্ঠা2.24B

    পরিচালক হিসাবে Neil Sharp এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Kelly Sharp এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Alison Vandyken এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠাF2.18

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    27 পৃষ্ঠা2.17B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    10 পৃষ্ঠা2.16B

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed N.G.S. print finishers LIMITED\certificate issued on 25/03/11
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ০৩ মার্চ, ২০১১

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ জুল, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ সেপ, ২০১০

    ২৬ সেপ, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    ২৪ জুল, ২০১০ তারিখে Kelly Sharp-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Neil George Sharp-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Ms Alison Grace Vandyken-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ আগ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    PRINT REALISATIONS 2011 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SHARP, Keith James
    34 Nuthurst
    RG12 0UN Bracknell
    Berkshire
    সচিব
    34 Nuthurst
    RG12 0UN Bracknell
    Berkshire
    British59863730001
    SHARP, Kelly
    15 Little Fryth
    Hollybush
    RG40 3RN Finchampstead
    Berkshire
    সচিব
    15 Little Fryth
    Hollybush
    RG40 3RN Finchampstead
    Berkshire
    British99942380001
    VANDYKEN, Alison Grace
    Little King Street
    BS1 4HW Bristol
    1-2
    সচিব
    Little King Street
    BS1 4HW Bristol
    1-2
    British91058950001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    SHARP, Kelly
    Perivale Park, Horsenden Lane South
    Perivale
    UB6 7RL Greenford
    Units 7-10
    Middlesex
    United Kingdom
    পরিচালক
    Perivale Park, Horsenden Lane South
    Perivale
    UB6 7RL Greenford
    Units 7-10
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director99942380003
    SHARP, Neil George
    Little King Street
    BS1 4HW Bristol
    1-2
    পরিচালক
    Little King Street
    BS1 4HW Bristol
    1-2
    EnglandBritishPrint Finisher54185900006

    PRINT REALISATIONS 2011 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    20Q5 sakuri/trumax spot uv 09320505641/00485/01912505250/1295/05/10. 2005 col tee collator C1464/14/28. 2004 mbo B30/644 folding machine W07/70 see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Asset Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1999 m/m stacker s/n ka 970 3298; 1999 muller martini prima 6 station sap 137954; 2004 autobond compact 102 t (p) s/n 0402127. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Surrey Asset Finance LTD
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ জুল, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মে, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £23,500. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Postel Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £34,780.00 together with ant lesser sum or greater sum. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Postel Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £34,780.00 together with any lesser sum or greater sum. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Postel Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £34,780.00 together with any lesser sum or greater sum. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Postel Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Muller martini saddle stitcher s/no: sap 137954, muller martini 1529 cover feeder s/no: sap 137702, muller martini practico stacker s/no: KA97.03298.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জানু, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £30,000.00 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A first fixed charge over the deposit fund.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Radiall Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ জানু, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জানু, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £30,000 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A fixed first charge over the deposit fund.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Radiall Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ জানু, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ১৯৯৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    PRINT REALISATIONS 2011 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০২ মার্চ, ২০১১প্রশাসন শুরু
    ০২ জুল, ২০১২প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    David Alan Rolph
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    অভ্যাসকারী
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Stephen Anthony John Ramsbottom
    1-2 Little King Street
    BS1 4HW Bristol
    অভ্যাসকারী
    1-2 Little King Street
    BS1 4HW Bristol

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0