COX MANAGING AGENCY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCOX MANAGING AGENCY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03096252
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    COX MANAGING AGENCY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9999) /

    COX MANAGING AGENCY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    COX MANAGING AGENCY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CENTREOFFER LIMITED২৯ আগ, ১৯৯৫২৯ আগ, ১৯৯৫

    COX MANAGING AGENCY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১০

    COX MANAGING AGENCY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ১৯ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠা4.68

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    4 পৃষ্ঠা4.71

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    3 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২০ মার্চ, ২০১২ তারিখে

    LRESSP

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৭ মে, ২০১১

    ২৭ মে, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 425,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে David Andrew Turner-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Deryck Brown এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ০২ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Victoria Louise Cuggy-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH03

    ০২ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Victoria Louise Cuggy-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ০২ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Deryck Justin Brown-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    2 পৃষ্ঠা122

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    16 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    অনুমোদিত শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES05
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩০ জুন, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩০ জুন, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    COX MANAGING AGENCY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CUGGY, Victoria Louise
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    সচিব
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    British105782010002
    CUGGY, Victoria Louise
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    পরিচালক
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritishCompany Secretary105782010002
    TURNER, David Andrew
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    পরিচালক
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritishSenior Accountant116524040001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    সচিব
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    BritishCompany Secretary85213650001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    21 Burrow Road
    SE22 8DU London
    সচিব
    21 Burrow Road
    SE22 8DU London
    British63143680001
    RINGROSE, Christopher James
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    সচিব
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    British46372950001
    ROSSER, Jill Rowena
    8 Belgrade Road
    TW12 2AZ Hampton
    Middlesex
    সচিব
    8 Belgrade Road
    TW12 2AZ Hampton
    Middlesex
    BritishCompany Secretary27339680002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BREWSTER, Richard Mark
    The Sun House, Basted Lane
    Crouch, Borough Green
    TN15 8PZ Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    The Sun House, Basted Lane
    Crouch, Borough Green
    TN15 8PZ Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishFinance Director86624170001
    BROWN, Deryck Justin
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    পরিচালক
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    United KingdomBritishAccountant123356160001
    COLTHURST, Henry Nicholas Almroth
    Asserton House
    Berwick St James
    SP3 4TZ Salisbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    Asserton House
    Berwick St James
    SP3 4TZ Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector168690530001
    CUGGY, Victoria Louise
    1 Canon Road
    Little Dunmow
    CM6 3GF Dunmow
    Essex
    পরিচালক
    1 Canon Road
    Little Dunmow
    CM6 3GF Dunmow
    Essex
    BritishCompany Secretary105782010001
    DAWSON, Michael George
    Finkley House
    Finkley
    SP11 6AE Andover
    Hampshire
    পরিচালক
    Finkley House
    Finkley
    SP11 6AE Andover
    Hampshire
    EnglandBritishLloyds Underwriter43588680002
    ELSTON, Andrew Henry
    Heatleys Cottage
    Middle Road
    CM13 3QW Ingrave
    Essex
    পরিচালক
    Heatleys Cottage
    Middle Road
    CM13 3QW Ingrave
    Essex
    BritishChartered Accountant98994410001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    পরিচালক
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    BritishCompany Secretary85213650001
    JENKS, Paul Holt
    Winscot Deaks Lane
    Cuckfield
    RH17 5JB West Sussex
    পরিচালক
    Winscot Deaks Lane
    Cuckfield
    RH17 5JB West Sussex
    BritishLloyds Underwriter77194910001
    PEXTON, Richard Anthony
    5 Endlesham Road
    SW12 8JX London
    পরিচালক
    5 Endlesham Road
    SW12 8JX London
    BritishLloyd'S Underwriter36011070002
    RINGROSE, Christopher James
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    পরিচালক
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishChartered Accountant46372950001
    SCOTT, David Hall
    23 Brokes Crescent
    RH2 9PS Reigate
    Surrey
    পরিচালক
    23 Brokes Crescent
    RH2 9PS Reigate
    Surrey
    BermudianInsurance Underwriter53233630001
    TURNER, David Andrew
    8 Bradley Close
    SS7 3AQ Benfleet
    Essex
    পরিচালক
    8 Bradley Close
    SS7 3AQ Benfleet
    Essex
    EnglandBritishSenior Accountant116524040001
    TYRWHITT, John Edward Charles
    Buckhurst Horns Road
    TN18 4QU Hawkhurst
    Kent
    পরিচালক
    Buckhurst Horns Road
    TN18 4QU Hawkhurst
    Kent
    BritishFinance Director65837920001
    VINCENT, Paul John
    Field House
    Hockering Road
    GU22 7HJ Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Field House
    Hockering Road
    GU22 7HJ Woking
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant82872630001
    WARDLE, David Charles
    63 Ashingdon Heights
    SS4 3TH Rochford
    Essex
    পরিচালক
    63 Ashingdon Heights
    SS4 3TH Rochford
    Essex
    United KingdomBritishAccountant108018670001
    WILLS, Richard Frederick De Leigh
    Lollesworth Farm
    KT24 6HN West Horsley
    Surrey
    পরিচালক
    Lollesworth Farm
    KT24 6HN West Horsley
    Surrey
    EnglandBritishLloyd'S Underwriter13952230001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    COX MANAGING AGENCY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the trustee for the secured parties or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charges over the undertaking over the real property, the accounts, the insurance policies, the proceeds thereof and all related rights, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital, the investments, the shares, all dividends, interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights, all monetary claims; and each of the specific contracts, floating charge subject to the security under the original debenture;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৭ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ আগ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Investment Bank PLC (As Trustee for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ৩১ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ আগ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A subordination and security trust deed dated 25 april 2002 made between the company and the obligors listed in schedule 3 to this form 395 (the "original obligors), hsbc investment bank PLC (the "trustee" and "agent") and the lenders listed in schedule 4 to this form 395 (the "orignal lenders").
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities now or at any time in the future due, owing or incurred by the obligors to secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company has covenanted and agreed that in the event of payment or discharge (whether in cash, by way of transfer of shares or other assets, set-off or counterclaim or otherwise) being made to, or an encumbrance being held by, the company in breach of clause 3.2 (prohibited payments and security) of the subordination and security trust deed, it will pay or transfer to the trustee for application in accordance with the terms of clause 7 (application of proceeds) of the subordination and security trust deed any sums or other assets which shall have been received or retained by it in consequence of such breach (whereupon the underlying subordination debt equivalent to the payment made shall be deemed not to have been reduced) and, until such payment or transfer, the company shall hold such sums or other assets or such encumbrance (as the case may be) on trust for the trustee.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Investment Bank Plcas Agent and Trustee for the Secured Parties Under the Subordination and Security Trust Deed
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ আগ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    COX MANAGING AGENCY LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৮ জুল, ২০১৩ভেঙে গেছে
    ২০ মার্চ, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0