PARK ROW GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPARK ROW GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03109700
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PARK ROW GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • আর্থিক সেবা হোল্ডিং কোম্পানির কার্যক্রম (64205) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম

    PARK ROW GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Central Square 8th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PARK ROW GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PARK ROW GROUP PLC০৭ মে, ২০০২০৭ মে, ২০০২
    BIRCHIN INTERNATIONAL PLC১৯ সেপ, ১৯৯৭১৯ সেপ, ১৯৯৭
    RUSHMERE WYNNE GROUP PLC২৮ নভে, ১৯৯৫২৮ নভে, ১৯৯৫
    MARKETCOIN PUBLIC LIMITED COMPANY০৩ অক্টো, ১৯৯৫০৩ অক্টো, ১৯৯৫

    PARK ROW GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    PARK ROW GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    17 পৃষ্ঠাLIQ14

    ২৪ এপ্রি, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    20 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৪ অক্টো, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Benson House 33 Wellington Street Leeds LS1 4JP থেকে Central Square 8th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ২৪ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    17 পৃষ্ঠা4.68

    ২৪ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    11 পৃষ্ঠা4.68

    চার্জ 10 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 9 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 6 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 2 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    5 পৃষ্ঠা4.20

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন

    LRESEX

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ অক্টো, ২০১৩

    ১০ অক্টো, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 70,728,395
    SH01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Ambant Limited Lloyds Avenue House 6 Lloyds Avenue London EC3N 3AX থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    27 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    28 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    PARK ROW GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COPPELL, Helen
    Chalky Bank Road
    Rainham
    ME8 7NP Gillingham
    27
    Kent
    সচিব
    Chalky Bank Road
    Rainham
    ME8 7NP Gillingham
    27
    Kent
    British159189030001
    CRABB, Steven Lee
    The Byeway
    WD31 1JW Rickmansworth
    2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Byeway
    WD31 1JW Rickmansworth
    2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish93134850002
    GRANT, Philip James
    Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Clay Chimneys House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Clay Chimneys House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34492660002
    ADAMS, Derek Stanley
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    সচিব
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    British45970110001
    CHAUDHRI, Farzana
    Oaklands
    Oudle Lane
    SG10 6DQ Much Hadham
    Hertfordshire
    সচিব
    Oaklands
    Oudle Lane
    SG10 6DQ Much Hadham
    Hertfordshire
    British55239490003
    CONNOLLY, William Stephen
    3 Dodleston Close
    CH43 9QZ Birkenhead
    Merseyside
    সচিব
    3 Dodleston Close
    CH43 9QZ Birkenhead
    Merseyside
    British86840740001
    LITTLE, David Anthony
    100 Kyrle Road
    SW11 6BA London
    সচিব
    100 Kyrle Road
    SW11 6BA London
    British77215960002
    MARKS, David Jeffrey
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    সচিব
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    British78129600001
    STEVENSON, Sandra Maureen
    197 Cotefield Drive
    LU7 8DW Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    সচিব
    197 Cotefield Drive
    LU7 8DW Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British48454410001
    EMCEE NOMINEES LIMITED
    First Floor 31 Southampton Row
    WC1B 5HT London
    কর্পোরেট সচিব
    First Floor 31 Southampton Row
    WC1B 5HT London
    38708590001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    কর্পোরেট সচিব
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ABBOTT, Richard David
    The Old Parsonage
    Church Street, Ropley
    SO24 0DS Hampshire
    পরিচালক
    The Old Parsonage
    Church Street, Ropley
    SO24 0DS Hampshire
    EnglandBritish78205110001
    ADAMS, Derek Stanley
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    পরিচালক
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    British45970110001
    ALBERGE, Maurice Ernest
    27 Glenloch Road
    NW3 4DJ London
    পরিচালক
    27 Glenloch Road
    NW3 4DJ London
    British49539510001
    ALLSUP, Mark William
    34 Dewhurst Road
    W14 0ES London
    পরিচালক
    34 Dewhurst Road
    W14 0ES London
    British42154290002
    BAILEY, Martin
    Daisybank Drive
    CW11 4JR Sandbach
    Heathside
    Cheshire
    England
    পরিচালক
    Daisybank Drive
    CW11 4JR Sandbach
    Heathside
    Cheshire
    England
    EnglandBritish95450450003
    BURNETT, Steven Robert
    The Belfry Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Flintshire
    পরিচালক
    The Belfry Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Flintshire
    United KingdomBritish56044450001
    BURR, Reginald Ivor
    21 St James Close
    Prince Albert Road St Johns Wood
    NW8 7LG London
    পরিচালক
    21 St James Close
    Prince Albert Road St Johns Wood
    NW8 7LG London
    British70371780001
    BURR, Rosemary Karen
    8 Hamilton House
    NW8 9PN London
    পরিচালক
    8 Hamilton House
    NW8 9PN London
    British15659480001
    DAVIES, Elzbieta Krystyna
    Gravee Du Sud
    The Grange
    GY1 1RP St Peter Port
    Guernsey
    পরিচালক
    Gravee Du Sud
    The Grange
    GY1 1RP St Peter Port
    Guernsey
    British115958830001
    DAVIES, John Hamilton
    Denbies
    Bardfield Saling
    CM7 5EG Braintree
    Essex
    পরিচালক
    Denbies
    Bardfield Saling
    CM7 5EG Braintree
    Essex
    EnglandBritish62682160001
    DENHEEN, Peter Gerard
    3 Pitcullen Terrace
    PH2 7EQ Perth
    Perthshire
    পরিচালক
    3 Pitcullen Terrace
    PH2 7EQ Perth
    Perthshire
    British112863220001
    DOBSON, Kevin James, Dr
    9 Harris Close
    Spital
    CH63 9YX Wirral
    Merseyside
    পরিচালক
    9 Harris Close
    Spital
    CH63 9YX Wirral
    Merseyside
    EnglandBritish69819530006
    DRURY, Anthony Charles
    39 Redwood Glade
    LU7 3JT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    পরিচালক
    39 Redwood Glade
    LU7 3JT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    EnglandBritish78025460001
    FITZSIMMONS, Edward
    91 Glenferness Avenue
    Talbot Woods
    BH3 7ES Bournemouth
    Dorset
    পরিচালক
    91 Glenferness Avenue
    Talbot Woods
    BH3 7ES Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritish35037160002
    GARDENER, Edward Patrick Montgomery, Professor
    The Gables
    Gannock Park, Deganwy
    LL31 9PZ Conwy
    Gwynedd
    পরিচালক
    The Gables
    Gannock Park, Deganwy
    LL31 9PZ Conwy
    Gwynedd
    WalesBritish66368000001
    GARDNER, Colyn, Doctor
    5 Oakley Street
    SW3 5NN London
    পরিচালক
    5 Oakley Street
    SW3 5NN London
    British114586870001
    HARDY, Carol Margaret
    6 Bawson Court
    Gomersal
    BD19 4SA Cleckheaton
    West Yorkshire
    পরিচালক
    6 Bawson Court
    Gomersal
    BD19 4SA Cleckheaton
    West Yorkshire
    EnglandBritish89078690001
    LASSEN, Richard Guy
    The Coach House
    27 Southern Road
    SO41 9HR Lymington
    Hampshire
    পরিচালক
    The Coach House
    27 Southern Road
    SO41 9HR Lymington
    Hampshire
    EnglandBritish111572370001
    MAPES, Pamela
    75 Greenside Road
    W12 9JQ London
    পরিচালক
    75 Greenside Road
    W12 9JQ London
    British60465150001
    MARKS, David Jeffrey
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    পরিচালক
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    EnglandBritish78129600001
    MCGREGOR, George
    7 Westmoreland Road
    PR8 6NX Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    7 Westmoreland Road
    PR8 6NX Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish88000730002
    MCGREGOR, George
    94 Forest Road
    PR8 6HY Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    94 Forest Road
    PR8 6HY Southport
    Merseyside
    British88000730001
    MINNS, Anthony Stirling
    Stoney Ridge House
    Headley Road Grayshott
    GU26 6DP Hindhead
    Surrey
    পরিচালক
    Stoney Ridge House
    Headley Road Grayshott
    GU26 6DP Hindhead
    Surrey
    United KingdomBritish1852650004

    PARK ROW GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security over shares agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from ambant limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    40,849,000 ordinary shares of £1 of park row associates limited and the related assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Liver (Ifa Holdings) PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £5875.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £5875.00.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bw Sipp Trustees Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    তৈরি করা হয়েছে ১১ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All stocks shares bonds debentures or other securities deposited with the bank and any bonus or other new securities and all rights,moneys or property accruing. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold property known as blue bridge house (essex); t/no EX431528.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") and by any other company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Bluebridge house colchester road halstead braintree district essex t/no EX431528. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a plot 155 princes riverside t/n 384711 the goodwill and connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Aib Group (UK) PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £20,775 to be held by the landlord on deposit of a separate designated interest bearing account in england bearing interest at a competitive rate available in the market for such long term deposits at the bank of scotland in the name of the landlord
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The rent interest or any other moneys payable to the landlord pursuant to a lease dated 1/4/98 (as defined) over premises on the 6TH floor of 1/6 lombard st,london EC3 may be withdrawn from the deposit account if the tenant does not pay after the 21 days time limit. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Scottish Provident Institution
    ব্যবসায়
    • ০৩ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Aib Group (UK) PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    • ১৩ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    PARK ROW GROUP LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৫ সেপ, ২০১৮ভেঙে গেছে
    ২৫ এপ্রি, ২০১৪ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Ian C. Oakley-Smith
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0